SOLOR CARE LONDON (3) LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSOLOR CARE LONDON (3) LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04255660
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SOLOR CARE LONDON (3) LTD?

    • Betreuungseinrichtungen für ältere und behinderte Menschen (87300) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich SOLOR CARE LONDON (3) LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Voyage Care Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SOLOR CARE LONDON (3) LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ROBINIA CARE LONDON (3) LIMITED28. Mai 200228. Mai 2002
    ROBINIA PROPERTIES (3) LIMITED06. Aug. 200106. Aug. 2001
    AMESLODGE LIMITED19. Juli 200119. Juli 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SOLOR CARE LONDON (3) LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SOLOR CARE LONDON (3) LTD?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für SOLOR CARE LONDON (3) LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Juli 2015

    Kapitalaufstellung am 02. Juli 2015

    • Kapital: GBP 249,901
    SH01

    Ernennung von Mr Philip Andre Sealey als Direktor am 09. Jan. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Kevin Wei Roberts als Geschäftsführer am 09. Jan. 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014

    19 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Juli 2014

    Kapitalaufstellung am 07. Juli 2014

    • Kapital: GBP 249,901
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013

    17 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Garrick House 2 Queen Street Lichfield Staffordshire WS13 6QD* am 25. Sept. 2013

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr Kevin Wei Roberts als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Kevin Wei Roberts als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Bruce Mckendrick als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    legacy

    28 SeitenMG01

    Beschlüsse

    Resolutions
    5 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    18 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Carriage Court 25 Circus Mews Bath Somerset BA1 2PW* am 03. Mai 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung von Bruce Mckendrick als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Andrew Winning als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Philip Sealey als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Christina Bailey als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Roland Perry als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Kit Doleman als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von SOLOR CARE LONDON (3) LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SEALEY, Philip
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Sekretär
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    British168863760001
    SEALEY, Philip Andre
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    EnglandBritishCompany Secretary45325360001
    WINNING, Andrew
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Geschäftsführer
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishNone73772160002
    ARTHUR, Simon David
    128 The Oaks
    RG14 7UZ Newbury
    Berkshire
    Sekretär
    128 The Oaks
    RG14 7UZ Newbury
    Berkshire
    BritishSolicitor79790640004
    BAILEY, Christina
    Carriage Court
    25 Circus Mews
    BA1 2PW Bath
    Somerset
    Sekretär
    Carriage Court
    25 Circus Mews
    BA1 2PW Bath
    Somerset
    148289130001
    BAILEY, John Christopher Leeksma
    Crane Grove
    N7 8LD London
    23
    Sekretär
    Crane Grove
    N7 8LD London
    23
    BritishSolicitor18758630003
    DOLEMAN, Kit
    Priory Road
    West Bridgford
    NG2 5HU Nottingham
    31
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Priory Road
    West Bridgford
    NG2 5HU Nottingham
    31
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    BritishCeo135491940001
    HARRISON, Adam Chapman
    42 Marina Drive
    Staverton
    BA14 8UR Trowbridge
    Wiltshire
    Sekretär
    42 Marina Drive
    Staverton
    BA14 8UR Trowbridge
    Wiltshire
    BritishDirector77287140001
    MCGINN, Benjamin John
    11 Maurice Road
    St Andrews
    BS6 5BZ Bristol
    Sekretär
    11 Maurice Road
    St Andrews
    BS6 5BZ Bristol
    BritishFinance Director61212620003
    SPOORS, Mark
    Carriage Court
    BA1 2PW Bath
    Banes
    Sekretär
    Carriage Court
    BA1 2PW Bath
    Banes
    BritishFinance Director120580980001
    THORNTON, Martin Hewson
    18 Church Road
    Silverton
    EX5 4HS Exeter
    Sekretär
    18 Church Road
    Silverton
    EX5 4HS Exeter
    BritishSolicitor5068830001
    L & A SECRETARIAL LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Bevollmächtigter Sekretär
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001450001
    BAINS, Satwant Singh
    8 Waldemar Road
    Wimbledon
    SW19 7LJ London
    Geschäftsführer
    8 Waldemar Road
    Wimbledon
    SW19 7LJ London
    BritishChief Executive Officer94530450001
    BALL, Julian Charles
    Mill Fleam
    Hilton
    DE65 5HE Derby
    14
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Mill Fleam
    Hilton
    DE65 5HE Derby
    14
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector138044110001
    BROOKES, Richard Dennis
    Cress Farm House
    High Street
    CV37 8EA Welford On Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Cress Farm House
    High Street
    CV37 8EA Welford On Avon
    Warwickshire
    EnglandBritishChart Surveyor81219580001
    DOLEMAN, Kit
    Priory Road
    West Bridgford
    NG2 5HU Nottingham
    31
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Priory Road
    West Bridgford
    NG2 5HU Nottingham
    31
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCeo135491940001
    FORD, Katherine Frances
    Carriage Court
    25 Circus Mews
    BA1 2PW Bath
    Somerset
    Geschäftsführer
    Carriage Court
    25 Circus Mews
    BA1 2PW Bath
    Somerset
    United KingdomBritishDirector138136380001
    HARRISON, Adam Chapman
    42 Marina Drive
    Staverton
    BA14 8UR Trowbridge
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    42 Marina Drive
    Staverton
    BA14 8UR Trowbridge
    Wiltshire
    BritishDirector77287140001
    MCGINN, Benjamin John
    11 Maurice Road
    St Andrews
    BS6 5BZ Bristol
    Geschäftsführer
    11 Maurice Road
    St Andrews
    BS6 5BZ Bristol
    United KingdomBritishFinance Director61212620003
    MCKENDRICK, Bruce
    Garrick House
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Garrick House
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Staffordshire
    UkBritishNone157088060001
    PERRY, Roland Robert Joseph
    Race Farm Lane
    Kingston
    OX13 5AY Bagpuize
    Race Farm
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Race Farm Lane
    Kingston
    OX13 5AY Bagpuize
    Race Farm
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector139021390001
    ROBERTS, Kevin Wei
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Geschäftsführer
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishCompany Director72030660002
    SILLIS, Paul Jeremy
    33 Lavington Road
    Ealing
    W13 9NN London
    Geschäftsführer
    33 Lavington Road
    Ealing
    W13 9NN London
    United KingdomBritishSolicitor11326600001
    SPOORS, Mark
    Carriage Court
    BA1 2PW Bath
    Banes
    Geschäftsführer
    Carriage Court
    BA1 2PW Bath
    Banes
    BritishFinance Director120580980001
    VON MALACHOWSKI, Glen
    Canada Farm House
    Captains Hill
    BA9 6HA Kinwartin
    Alcester
    Geschäftsführer
    Canada Farm House
    Captains Hill
    BA9 6HA Kinwartin
    Alcester
    EnglandBritishDirector66391980002
    WAGSTAFF, Elizabeth Anne
    Abbey Rectory
    Park Lane
    BA1 2XH Bath
    Geschäftsführer
    Abbey Rectory
    Park Lane
    BA1 2XH Bath
    BritishDirector43422820004
    L & A REGISTRARS LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001440001

    Hat SOLOR CARE LONDON (3) LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 25. Jan. 2013
    Geliefert am 04. Feb. 2013
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any member of the group to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2013Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 31. März 2009
    Geliefert am 09. Apr. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of properties charged, please refer to form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Apr. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Jan. 2006
    Geliefert am 01. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties) (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Apr. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 24. Juli 2003
    Geliefert am 01. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land being 1 sheringham avenue london N14 4UB t/n AGL93817, f/h land being 47 streatham common london SW16 3HS t/n 279476, f/h land being lumley house 1 south avenue chellaston derby DE73 1RS city of derby t/n DY220368, for details of further properties charged please refer to the from 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Mai 2003
    Geliefert am 20. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as 18 aquaduct road shirley t/n WM754973. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Mai 2003
    Geliefert am 20. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 126 castle lane olton t/n WM158805. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Mai 2003
    Geliefert am 20. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 54 brookvale road olton t/n WK221463. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Feb. 2003
    Geliefert am 12. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property k/a 1 south avenue (also k/a lumley house) chellaston derby y/n DY220368. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. Feb. 2003
    Geliefert am 12. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property k/a 1 south avenue chellaston derby t/n DY220368. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Jan. 2003
    Geliefert am 07. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 12 channel lea walmer deal kent t/no K449781. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. Dez. 2002
    Geliefert am 11. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including the f/hold known as 28 woolston rd,butlocks heath,hampshire; HP158889. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Dez. 2002
    Geliefert am 11. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as 28 woolston rd,butlocks heath,hampshire; t/no hp 158889. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Okt. 2002
    Geliefert am 29. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 74 sir evelyn road rochester t/n K608109. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Okt. 2002
    Geliefert am 29. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The property k/a 74 sir evelyn road rochester kent t/n K608109. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Mai 2002
    Geliefert am 30. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as robinia properties (3) limited) to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 47 streatham common north, london t/no. 279467. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Nov. 2001
    Geliefert am 15. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 1 sheringham avenue, london, N14 4UB, t/no AGL93817.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Okt. 2001
    Geliefert am 15. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 49 crabble hill, dover, kent, CT17 0RX, t/no K613388.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Okt. 2001
    Geliefert am 15. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0