PAVEMENTS (UK) NO.1 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PAVEMENTS (UK) NO.1 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04256682 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PAVEMENTS (UK) NO.1 LIMITED?
- Tätigkeit von Holdinggesellschaften für Finanzdienstleistungen (64205) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich PAVEMENTS (UK) NO.1 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Gesch äftstelle | 8 Princes Parade L3 1QH Liverpool |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PAVEMENTS (UK) NO.1 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| QUAIL (THE PAVEMENTS) LIMITED | 07. Jan. 2002 | 07. Jan. 2002 |
| CPPL (THE PAVEMENTS) LIMITED | 23. Juli 2001 | 23. Juli 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PAVEMENTS (UK) NO.1 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PAVEMENTS (UK) NO.1 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 18 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 4th Floor, 25/26 Khiara House Poland Street London W1F 8QN England zum 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH am 10. Dez. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Dmms Ltd 3rd Floor 26-28 Great Portland Street London W1W 8QT zum 4th Floor, 25/26 Khiara House Poland Street London W1F 8QN am 16. Aug. 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 042566820006 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||||||||||||||
Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 5 | 2 Seiten | MR05 | ||||||||||||||||||||||||||
Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 042566820007 | 1 Seiten | MR05 | ||||||||||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juli 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2020 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juli 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 37 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 26. Juli 2019
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||||||||||
Änderung der Bezeichnung der Aktienklasse | 2 Seiten | SH08 | ||||||||||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 11 Seiten | AA | ||||||||||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PAVEMENTS (UK) NO.1 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAYNE, Padraig Anthony | Sekretär | Garvagh House Donaghmore BT70 3LS Dungannon Tyrone N Ireland | Irish | 144154580001 | ||||||||||
| DRAYNE, Padraig Anthony | Geschäftsführer | Garvagh House Donaghmore BT70 3LS Dungannon Tyrone N Ireland | Northern Ireland | Irish | 144154580001 | |||||||||
| MCCRORY, Shane | Geschäftsführer | Garvagh Road BT70 3LS Dungannon 8a County Tyrone Northern Ireland | Northern Ireland | Irish | 205090580001 | |||||||||
| MAUD, Glenn | Sekretär | 17 Earls Terrace Kensington W8 6LP London | British | 77818210001 | ||||||||||
| PATEL, Sunil | Sekretär | 56 Woodhill Crescent Kenton HA3 0LY Harrow Middlesex | British | 54145950002 | ||||||||||
| SCOTT, Keith | Sekretär | 4 Bakers Walk HP22 5YP Weston Turville Buckinghamshire | British | 75221310001 | ||||||||||
| D.W. COMPANY SERVICES LIMITED | Sekretär | 4th Floor, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh | 613080003 | |||||||||||
| SF SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | St Vincent Street G2 5HF Glasgow 130 United Kingdom |
| 900029010001 | ||||||||||
| BEASLEY, Paul | Geschäftsführer | Well Cottage Sundridge Road Ide Hill TN14 6JS Sevenoaks Kent | England | British | 21950670002 | |||||||||
| BRADLEY, Pauline Anne | Geschäftsführer | Spruce Tree House By Gleneagles PH4 1RG Auchterarder Perthshire | British | 122926460001 | ||||||||||
| CUMMINGS, Peter Joseph | Geschäftsführer | Glen View 6 Barloan Crescent G82 2AT Dumbarton Dunbartonshire | Scotland | British | 68241910003 | |||||||||
| DRAYNE, Kevin Brendan | Geschäftsführer | Garvagh House Donaghmore BT70 3LS Dungannon Tyrone N Ireland | Northern Ireland | Northern Irish | 116271580001 | |||||||||
| ELLINTHORPE, Bryan | Geschäftsführer | 76 Lock Chase Blackheath SE3 9HA London | British | 13281360001 | ||||||||||
| KASCH, Peter Carwile | Geschäftsführer | 7 St Georges Road TN13 3ND Sevenoaks Kent | British | 61386600002 | ||||||||||
| KERR, Donald | Geschäftsführer | 28 Burnbank EH20 9NE Straiton Midlothian | British | 84247450001 | ||||||||||
| MAUD, Glenn | Geschäftsführer | 17 Earls Terrace Kensington W8 6LP London | England | British | 77818210001 | |||||||||
| MAUD, Patricia Ann | Geschäftsführer | 17 Earls Terrace Kensington W8 6LP London | British | 77816490001 | ||||||||||
| MCLAUGHLIN, Gabriel Joseph Paul | Geschäftsführer | 77 Clifton Hill St Johns Wood NW8 0JN London | United Kingdom | British | 114724640001 | |||||||||
| MURPHY, Raymond | Geschäftsführer | 84 Granville Road Cabinteely IRISH Dublin Ireland | Irish | 104620220001 | ||||||||||
| O'HARE, Genevieve | Geschäftsführer | 23 Gloucester Avenue Primrose Hills NW1 7AU London | Irish | 99750000001 | ||||||||||
| TRIBE, Nicholas John Grove | Geschäftsführer | Yew Tree Cottage Sherbourne Street, Edwardstone CO10 5PD Sudbury Suffolk | United Kingdom | British | 141163390001 | |||||||||
| WOOD, Jonathan Caller | Geschäftsführer | 15 Stanhope Way Riverhead TN13 2DZ Sevenoaks Kent | British | 36486310001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PAVEMENTS (UK) NO.1 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Padraig Anthony Drayne | 06. Apr. 2016 | Garvagh Road BT70 3LS Dungannon 8 Northern Ireland | Nein |
Nationalität: Irish Staatsangehörigkeit: Northern Ireland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Patrick Mckillen | 06. Apr. 2016 | Hume Street Dublin 2 15 Ireland | Nein |
Nationalität: Irish Staatsangehörigkeit: Ireland | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat PAVEMENTS (UK) NO.1 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 12. Dez. 2014 Geliefert am 02. Jan. 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung The pavements new beetwell street chesterfield t/no DY231907. The bewise unit comprising part of the pavements chesterfield. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 30. Mai 2013 Geliefert am 04. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Apr. 2005 Geliefert am 19. Apr. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the quail (chesterfields) limited and chesterfield (the pavements) subsidiary limited on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a the pavement shopping centre chesterfield t/n DY231907. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Mai 2004 Geliefert am 02. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrowers, each property owning subsidiary or any other obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h land known as the pavements shopping centre chesterfield t/no DY231907 and other land together with all rights in buildings structures erections fixtures and fittings. Assigns a) rental income b) occupational leases and other documents c) insurance d) external hedging agreements. By way of fixed charge chattels, goodwill, bank accounts, book and other debts, shares, intellectual property rights, licences and other documents. By way of floating charge all assets not mortgaged charged or assigned. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Mai 2004 Geliefert am 28. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land known as ecm tower (formerly known as data general tower) great west road brentford middlesex t/no AGL16790, the l/h land known as the pavements shopping centre chesterfield t/no DY231907 and the f/h and l/h land known as prescot shopping centre prescot merseyside t/nos MS372823 and MS456161. For details of further properties charged please refer to form 395. assignment of rental income and occupational leases and other documents. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third party debenture | Erstellt am 05. Dez. 2003 Geliefert am 19. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from pavement shopping centre limited to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 2001 Geliefert am 09. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly k/a cppl (the pavements) limited to the chargee and any other finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat PAVEMENTS (UK) NO.1 LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0