THE DAY SPA PROPERTIES (UK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | THE DAY SPA PROPERTIES (UK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04259727 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THE DAY SPA PROPERTIES (UK) LIMITED?
- (7011) /
- (7012) /
- (7020) /
Wo befindet sich THE DAY SPA PROPERTIES (UK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | North House 17 North John Street L2 5EA Liverpool Merseyside |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von THE DAY SPA PROPERTIES (UK) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ESSZENCIA LIMITED | 31. Aug. 2001 | 31. Aug. 2001 |
| NEATSAIL LIMITED | 26. Juli 2001 | 26. Juli 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE DAY SPA PROPERTIES (UK) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THE DAY SPA PROPERTIES (UK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Timothy Molloy am 26. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2009 bis 31. März 2010 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2004 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THE DAY SPA PROPERTIES (UK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVELADY, Andrew Robert | Sekretär | 50 Tollemache Road CH43 8SZ Prenton Merseyside | British | 41693730006 | ||||||
| SILVANO, Helen | Sekretär | The Stables 1b Grange Park Maghull L31 3DP Liverpool Merseyside | British | 55343270002 | ||||||
| LEWIS, Carl Alexander | Geschäftsführer | Badgers Croft Caldy Wood Caldy CH48 2LT Wirral Merseyside | United Kingdom | British | 52633210001 | |||||
| LOVELADY, Andrew Robert | Geschäftsführer | 50 Tollemache Road CH43 8SZ Prenton Merseyside | United Kingdom | British | 41693730006 | |||||
| MOLLOY, Timothy | Geschäftsführer | 20 Knightsbridge Avenue CW9 8GE Northwich Cheshire | England | British | 75847410001 | |||||
| OWEN, Michael Barry | Geschäftsführer | Barrow Lane Great Barrow CH3 7HW Chester The Old Rectory Cheshire | England | British | 69716360003 | |||||
| MASTERS, Michael David | Sekretär | 26 Bellpit Close Worsley M28 7XH Manchester Lancashire | British | 77738080001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| LEWIS, Elaine | Geschäftsführer | Badgers Croft Caldy CH48 Wirral | United Kingdom | British | 127496420001 | |||||
| MASTERS, Michael David | Geschäftsführer | 1 Stonewalls Rosemary Lane Burton Rossett LL12 0LG Wrexham Clwyd | Wales | British | 77738080002 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat THE DAY SPA PROPERTIES (UK) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 31. März 2006 Geliefert am 12. Apr. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H establishment medispa clinic, london road, adlington, macclesfield, t/no CH254445. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. März 2006 Geliefert am 05. Apr. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 19. Nov. 2004 Geliefert am 01. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or the customer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a land at london road, adlington, london, t/no CH254445. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Jan. 2003 Geliefert am 29. Jan. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £340,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All that f/h land k/a farra's restaurant and dean wood london road adlington and also liberty city bar and restaurant london road adlington t/n CH254445. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0