HILSTONE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

HILSTONE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHILSTONE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04265097
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HILSTONE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich HILSTONE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o BROOKS BUSINESS RECOVERY
    The Media Centre
    7 Northumberland Street
    HD1 1RL Huddersfield
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HILSTONE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SACKVILLE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED12. Sept. 200112. Sept. 2001
    FISEPA 135 LIMITED06. Aug. 200106. Aug. 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HILSTONE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. März 2013
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Dez. 2013
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für HILSTONE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Jan. 2017

    20 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 09. Feb. 2017

    19 Seiten2.35B

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 05. Dez. 2016

    2 Seiten3.6

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Juli 2016

    21 Seiten2.24B

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Juli 2016

    2 Seiten3.6

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Jan. 2016

    20 Seiten2.24B

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Jan. 2016

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Juli 2015

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Jan. 2015

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Juli 2014

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Juli 2015

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Jan. 2015

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Juli 2014

    2 Seiten3.6

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Juli 2015

    20 Seiten2.24B

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Juli 2015

    2 Seiten3.6

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Jan. 2015

    19 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Jan. 2015

    2 Seiten3.6

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    RM01

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    RM01

    Wer sind die Geschäftsführer von HILSTONE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BROOKES, Alan Marcus
    Exton Lodge
    Exton
    EX3 0PJ Exeter
    Devon
    Sekretär
    Exton Lodge
    Exton
    EX3 0PJ Exeter
    Devon
    British2066880001
    BOKENHAM, Michael Clifton Thomas
    South Park Lodge Carlton Road
    South Godstone
    RH9 8LD Godstone
    Surrey
    Geschäftsführer
    South Park Lodge Carlton Road
    South Godstone
    RH9 8LD Godstone
    Surrey
    United KingdomBritish11496510001
    BROOKES, Alan Marcus
    Exton Lodge
    Exton
    EX3 0PJ Exeter
    Devon
    Geschäftsführer
    Exton Lodge
    Exton
    EX3 0PJ Exeter
    Devon
    EnglandBritish2066880001
    WINTER, Mary Catherine
    29 Manor Road
    Whitchurch On Thames
    RG9 7EU South Oxfordshire
    Sekretär
    29 Manor Road
    Whitchurch On Thames
    RG9 7EU South Oxfordshire
    British58221870001
    WOOD SMITH, Ian Michael
    Sycamores
    The Coombe Streatley
    RG8 9QT Reading
    Berkshire
    Sekretär
    Sycamores
    The Coombe Streatley
    RG8 9QT Reading
    Berkshire
    British99780060001
    BRACKEN, Michael Ernest
    8 Enid Close
    Bricket Wood
    AL2 3EL St Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    8 Enid Close
    Bricket Wood
    AL2 3EL St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish25602350002
    BURROUGHS, Philip Anthony
    Floor
    1 Great Cumberland Place
    W1H 7AL London
    5th
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Floor
    1 Great Cumberland Place
    W1H 7AL London
    5th
    United Kingdom
    United KingdomBritish99791310004
    HICKIE, John Francis
    46 Woodlands Park
    DA5 2EL Bexley
    Kent
    Geschäftsführer
    46 Woodlands Park
    DA5 2EL Bexley
    Kent
    United KingdomUk Citizen16131610001
    HOMAN, Jonathan Philip
    Orchard Cottage
    Hockley Lane
    SL2 4QE Stoke Poges
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Orchard Cottage
    Hockley Lane
    SL2 4QE Stoke Poges
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish38068540001
    HOWE, Nigel
    Little Flexford House
    Andover Road, Highclere
    RG20 9PU Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Little Flexford House
    Andover Road, Highclere
    RG20 9PU Newbury
    Berkshire
    British68249210003
    MADEJSKI, Robert John, Sir
    Northcourt
    Pangbourne
    RG8 8PT Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Northcourt
    Pangbourne
    RG8 8PT Reading
    Berkshire
    EnglandBritish42866240001
    PARKES, Jeremy Guy
    1 Exeter Cottages
    The Coombe
    RG8 9QX Streatley
    Berkshire
    Geschäftsführer
    1 Exeter Cottages
    The Coombe
    RG8 9QX Streatley
    Berkshire
    United KingdomBritish103217230001
    WOOD SMITH, Ian Michael
    Sycamores
    The Coombe Streatley
    RG8 9QT Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Sycamores
    The Coombe Streatley
    RG8 9QT Reading
    Berkshire
    EnglandBritish99780060001

    Hat HILSTONE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 06. Aug. 2004
    Geliefert am 14. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as sackville property investments limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 339 high street slough t/n BK312276. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society as Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Aug. 2004
    Geliefert am 14. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    A loan of up to £27,500,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    L/H property situate at the north side of broadway old amersham t/n BM221320.
    Berechtigte Personen
    • Century Life PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Aug. 2004
    Geliefert am 14. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    A loan of up to £27,500,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the south side of monks way linford wood industrial estate t/ns BM177145 and BM178029.
    Berechtigte Personen
    • Century Life PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Aug. 2004
    Geliefert am 14. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    A loan of up to £27,500,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Property situate at bourne mills industrial estate bourne end hemel hempstead t/ns HD398497 HD47730 and HD403085.
    Berechtigte Personen
    • Century Life PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Aug. 2004
    Geliefert am 14. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    A loan of up to £27,500,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    339 high street slough t/n BK312276.
    Berechtigte Personen
    • Century Life PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Aug. 2004
    Geliefert am 14. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Aug. 2004
    Geliefert am 14. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property under t/no HD403085, HD247730 and HD398497 k/a bourne end mills industrial estate, bourne end. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society as Agent and as Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 218. Juli 2013Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
    • 220. Mai 2014Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
    • 228. Mai 2014Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
    • 210. Dez. 2016Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
    • 210. Dez. 2016Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 2
    Legal charge
    Erstellt am 06. Aug. 2004
    Geliefert am 14. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All teh f/h and l/h property under t/no's BM177145 (f/h) and BM178029 (l/h) and k/a dencora business park, linford wood, milton keynes. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society as Agent and as Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 118. Juli 2013Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
    • 119. März 2014Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
    • 120. Mai 2014Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
    • 110. Dez. 2016Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
    • 110. Dez. 2016Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 1
    Legal charge
    Erstellt am 06. Aug. 2004
    Geliefert am 14. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a land on the north side of broadway, old amersham buckinghamshire, t/no BM221320. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society as Agent and as Security Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Aug. 2003
    Geliefert am 09. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property church house and deacon house, st mary's court, old amersham, buckinghamshire t/n BM221320. By way of fixed charge its interest in all money under any insurance in respect of the property and assigned its interest in the rent, service charges and value added tax thereon.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Shares charge
    Erstellt am 08. Apr. 2003
    Geliefert am 12. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All investments,stocks,shares and other securities and all dividends,interest and other money payable; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment
    Erstellt am 08. Apr. 2003
    Geliefert am 12. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as 339 high st,slough berkshire; BK312276; all other freehold or leasehold property and all rent,fittings,plant,equipment,machinery,tools,vehicles,investment,goodwill and cash at bank; floating charge over all undertaking and property; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge on shares
    Erstellt am 07. Feb. 2003
    Geliefert am 14. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge over the investments and all dividends,interest and other money payable thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment and restatement of the debenture dated 7 december 2001
    Erstellt am 07. Feb. 2003
    Geliefert am 14. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including 339 high st,slough berkshire; f/hold t/no bk 312276. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charges on shares
    Erstellt am 09. Aug. 2002
    Geliefert am 15. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment and restatement in relation to a debenture and a deed of subordination dated 7 december 2001
    Erstellt am 09. Aug. 2002
    Geliefert am 15. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. März 2002
    Geliefert am 11. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Dencora business park brecklands linford wood milton keynes buckinghamshire MK14 6EY with freehold title number BM177145 and the leasehold property with title number BM178029 together with all insurance monies rent service charges and vat.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 11. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Feb. 2002
    Geliefert am 06. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land comprising part of bourne end mills industrial estate upper bourne end lane hemel hempstead hertfordshire HP1 2UJ t/no's:-HD398497 HD403085 and HD247730 and f/h land comprising part of bourne end mills industrial estate upper bourne end lane hemel hempstead HP1 2UJ HD404207 all insurance monies and all rent service charges and vat. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 06. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Dez. 2001
    Geliefert am 11. Dez. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat HILSTONE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Shelley Bullman
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Receiver Manager
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Simon Robert Thomas
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Receiver Manager
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Nicholas H O'Reilly
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Receiver Manager
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Shelley Bullman
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Receiver Manager
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Simon Robert Thomas
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Receiver Manager
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Nicholas H O'Reilly
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Receiver Manager
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    3
    DatumTyp
    14. Aug. 2013Beginn der Verwaltung
    09. Feb. 2017Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Charles Michael Brook
    The Media Centre 7 Northumberland Street
    HD1 1RL Huddersfield
    Praktiker
    The Media Centre 7 Northumberland Street
    HD1 1RL Huddersfield

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0