HOWGATE TWO LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HOWGATE TWO LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04269323 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HOWGATE TWO LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich HOWGATE TWO LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 52 Grosvenor Gardens SW1W 0AU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HOWGATE TWO LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HOWGATE TWO LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Richard Bourgeois als Geschäftsführer am 22. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Charles Appleyard als Geschäftsführer am 03. März 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Barry Steven Hill als Geschäftsführer am 03. März 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Bryan Womack als Geschäftsführer am 15. Okt. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Richard Bourgeois als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Xavier Pullen als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Falguni Desai als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stuart Andrew Wetherly als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Laxton als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 10 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Karen Fox als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 11 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HOWGATE TWO LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WETHERLY, Stuart Andrew | Sekretär | Grosvenor Gardens SW1W 0AU London 52 | 177484440001 | |||||||
| FORD, Kenneth Charles | Geschäftsführer | 43 Hans Place SW1X 0JZ London | England | British | 52710005 | |||||
| STAVELEY, Charles Andrew Rover | Geschäftsführer | Riverdale Gardens TW1 2BZ Twickenham 17 United Kingdom | England | British | 133771640001 | |||||
| DESAI, Falguni Rameshchandra | Sekretär | Apartment 108 20 Palace Street SW1E 5BA London | British | 77755390004 | ||||||
| OLSWANG COSEC LIMITED | Sekretär | 90 High Holborn WC1V 6XX London Seventh Floor | 83864780002 | |||||||
| APPLEYARD, Andrew Charles | Geschäftsführer | Poultry EC2R 8EJ London No 1 | United Kingdom | British | 131498200001 | |||||
| BARBER, Martin | Geschäftsführer | 8 Highfields Grove N6 6HN London | British | 35534320006 | ||||||
| BOURGEOIS, Mark Richard | Geschäftsführer | Grosvenor Gardens SW1W 0AU London 52 | England | British | 60776880004 | |||||
| BOYLAND, Roger Michael | Geschäftsführer | Flat 5 Wellesley House Lower Sloane Street SW1W 8AL London | British | 33984480006 | ||||||
| CLARK, Philip John | Geschäftsführer | 26 Bourne Avenue Southgate N14 6PD London | United Kingdom | British | 101932350001 | |||||
| COPELAND, Anne Marie | Geschäftsführer | 3 The Manor House Roxwell Road CM1 3RY Writtle Essex | United Kingdom | British | 87679960001 | |||||
| CORAL, Lynda Sharon | Geschäftsführer | Westacre 1a Sandy Lodge Road WD3 1LP Moor Park Hertfordshire | British | 34029880004 | ||||||
| FOX, Karen Julia | Geschäftsführer | The Roost Chinnor Road OX9 3QY Towersey Oxfordshire | British | 116116000001 | ||||||
| HILL, Barry Steven | Geschäftsführer | Macaulay Court SW4 0QU London Flat 3 | United Kingdom | British | 151020170001 | |||||
| JONES, Richard Peter | Geschäftsführer | Tudor House 11 Lower Street CM24 8LN Stansted | England | British | 76584200002 | |||||
| LAXTON, Chris James Wentworth | Geschäftsführer | The Green Saxlingham NR15 1TH Nethergate Grove Farm House Norfolk | United Kingdom | British | 198871760001 | |||||
| LEWIS PRATT, Andrew | Geschäftsführer | 34 Hillersdon Avenue Barnes SW13 0EF London | British | 60050050002 | ||||||
| NELL, Philip John Payton | Geschäftsführer | Bury Lodge Bury Lane Elmdon CB11 4NQ Saffron Walden Essex | England | British | 105566370001 | |||||
| PATTERSON, Christopher Lindsay | Geschäftsführer | 17 Chatsworth Avenue SW20 8JZ London | British | 86029780001 | ||||||
| PULLEN, Xavier | Geschäftsführer | 65 Studdridge Street SW6 3SL London | England | British | 78912170008 | |||||
| SUNNUCKS, William D'Urban | Geschäftsführer | East Gores Farm Salmons Lane CO6 1RZ Coggeshall Essex | England | British | 32866350001 | |||||
| WOMACK, Ian Bryan | Geschäftsführer | 6 Southwood Lawn Road Highgate N6 5SF London | England | British | 33902000006 | |||||
| OLSWANG DIRECTORS 1 LIMITED | Geschäftsführer | Third Floor 90 Long Acre Covent Garden WC2E 9TT London | 72502190001 | |||||||
| OLSWANG DIRECTORS 2 LIMITED | Geschäftsführer | 90 Long Acre Covent Garden WC2E 9TT London | 72502080001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HOWGATE TWO LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howgate Leasehold Limited | 06. Apr. 2016 | Esplanade St. Helier JE2 3QA Jersey One Channel Islands | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat HOWGATE TWO LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of charge (security and intercreditor deed) | Erstellt am 05. Mai 2005 Geliefert am 23. Mai 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company the borrower or any other obligor or any limited obligor to the obligor security trustee or any of the other obligor secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H and l/h property, specified assets, book debts, obligor security group shares, intellectual property, insurances, obligor transaction documents, net rental income, agreements floating charge all undertaking property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Obligor/issuer floating charge agreement | Erstellt am 05. Mai 2005 Geliefert am 18. Mai 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company, the borrower or (in the case of the obligors only)any other obligor or any limited obligor to the chargee, under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first floating charge, the whole of its undertaking and all property assets and rights present and future (including all stock in trade f/h and l/h property and balance standing to the credit of any client accounts),. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security presented for registration in scotland on 9 may 2005 and | Erstellt am 29. Apr. 2005 Geliefert am 12. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any and all of the obligors to each of or all of the obligor secured creditors or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects known as the howgate centre falkirk in the parish of falkirk and county of stirling t/n STG19728, the premises known as and forming units 1 1A 1B 2 3 and first floor premises howgate centre falkirk t/n stg 14756,. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 19 april 2004 and | Erstellt am 06. Apr. 2004 Geliefert am 30. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of the obligor to the security trustee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects comprising and k/a the howgate centre, falkirk in the parish of falkirk and the county of stirling t/n STG19728. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Apr. 2004 Geliefert am 16. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to the chargee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings to the south of main road romford (now k/a the dolphin centre) havering t/n EGL416981. L/h land and buildings lying to the north of western road romford (now k/a liberty ii shopping centre) havering t/n EGL347983. L/h land the upper deck car park mercury gardens romford t/n EGL435359 for details of further property charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 20. Okt. 2003 Geliefert am 07. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All assets rights and property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration on 10 may 2002 and | Erstellt am 02. Mai 2002 Geliefert am 17. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligor to the security trustee and each of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the premises k/a and forming units 1.1A,1B,2,3 and first floor premises, howgate centre, falkirk, t/no STG14756. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on the 21ST march 2002 | Erstellt am 28. Feb. 2002 Geliefert am 06. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligor to the chargee as security trustee for the finance parties (all terms as defined) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The howgate centre falkirk county of stirling t/no.STG19728. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Feb. 2002 Geliefert am 20. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All that leasehold land being broadway shopping centre broadway bexleyheath in the london borough of bexley t/n SGL553179, all that freehold land being land and buildings to the south of main road romford (now known as the dolphin centre) havering t/n EGL416981 and all that leasehold land being land and buildings lying to the north of western road romford (known as liberty ii shopping centre) havering EGL347983 (for further details of property charged see schedule 3 of form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Nov. 2001 Geliefert am 05. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities due or to become due from the company to any finance party (as defined) under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben First fixed charge over all estates or interests in any freehold or leasehold property with all plant machinery thereon; all moneys standing to the credit of any account with all benefits in respect of insurances and all claims/returns of premiums thereunder; all book and other debts and all other moneys due to the company and benefits of all rights,securities and guarantees; the goodwill of business,licences,consents,uncalled capital,shares and rights under any development agreement; all rental income and floating charge over all assets; see form 395 for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 4TH january 2002 | Erstellt am 30. Okt. 2001 Geliefert am 21. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The property known as the howgate centre, falkirk t/no. STG19728. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0