TWCL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TWCL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04274466 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TWCL LIMITED?
- Tätigkeit von Risikokapital- und Beteiligungsgesellschaften (64303) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich TWCL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Pearl Assurance House 319 Ballards Lane N12 8LY London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TWCL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| THE WEYBRIDGE CLUB LIMITED | 21. Aug. 2001 | 21. Aug. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TWCL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TWCL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 12 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Aug. 2021 | 13 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 319 Ballards Lane Pearl Assurance House London N12 8LY zum Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY am 24. Aug. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Albion Capital Group Llp 1 Benjamin Street London EC1M 5QL England zum 319 Ballards Lane Pearl Assurance House London N12 8LY am 24. Aug. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Cessation of Albion Technology & General Vct Plc as a person with significant control on 08. Juni 2020 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Benjamin Street C/O Albion Capital Group Llp 1 Benjamin Street London EC1M 5QG United Kingdom zum C/O Albion Capital Group Llp 1 Benjamin Street London EC1M 5QL am 22. Juli 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Albion Capital Group Llp 1 King's Arms Yard London EC2R 7AF United Kingdom zum 1 Benjamin Street C/O Albion Capital Group Llp 1 Benjamin Street London EC1M 5QG am 03. Juni 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Edward William Anthony Lascelles als Direktor am 26. März 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2018 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Mai 2018 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Notification of Albion Ventures Limited as a person with significant control on 15. Dez. 2017 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of William James Peaker as a person with significant control on 15. Dez. 2017 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Albion Ventures Llp, 1 King's Arms Yard London EC2R 7AF England zum C/O Albion Capital Group Llp 1 King's Arms Yard London EC2R 7AF am 26. Sept. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Change of details for Albion Ventures Llp as a person with significant control on 12. Juni 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Fritz Ternofsky als Geschäftsführer am 26. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TWCL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASCELLES, Edward William Anthony | Geschäftsführer | 319 Ballards Lane N12 8LY London Pearl Assurance House | United Kingdom | British | 78680750002 | |||||||||
| STANFORD, Henry Julian Aglionby | Geschäftsführer | 319 Ballards Lane N12 8LY London Pearl Assurance House | England | British | 62204660001 | |||||||||
| WATSON, Huw Spencer | Sekretär | Claremont House 83 Church Road Bishopsworth BS13 8JU Bristol | British | 77927160003 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| BRIDLE, Matt | Geschäftsführer | Walton Lane KT13 8QA Weybridge Walton Lane Surrey England | England | British | 209295990001 | |||||||||
| GIGOV, Emil Slavchev | Geschäftsführer | 10 Chapel Croft CM4 0BU Ingatestone Essex | England | Bulgarian | 71298890001 | |||||||||
| GILLIS, Neil Duncan | Geschäftsführer | High Street Thelnetham IP22 1JL Diss Thelnetham House Norfolk United Kingdom | England | British | 69204500003 | |||||||||
| GUDGIN, David | Geschäftsführer | Beaconsfield Terrace Road Kensington W14 0PP London 10 England England | United Kingdom | British | 122140390001 | |||||||||
| GUMM, Paul David | Geschäftsführer | Walton Lane KT13 8QA Weybridge Walton Lane Surrey England | England | British | 184209530001 | |||||||||
| LEBOFF, Rob Julian Daniel | Geschäftsführer | Walton Lane KT13 8QA Weybridge Walton Lane Surrey England | England | British | 182194040001 | |||||||||
| RUEDIG, Christoph Oliver | Geschäftsführer | Walton Lane KT13 8QA Weybridge Walton Lane Surrey England | United Kingdom | German | 179143110001 | |||||||||
| TERNOFSKY, Fritz | Geschäftsführer | King's Arms Yard EC2R 7AF London C/O Albion Ventures Llp, 1 England | England | Austrian | 211156430001 | |||||||||
| VAN LANSCHOT HUBRECHT, Jean Henri | Geschäftsführer | 9 Misbourne House Amersham Road HP8 4RY Chalfont St. Giles Buckinghamshire | England | Dutch | 63934990003 | |||||||||
| WATSON, Huw Spencer | Geschäftsführer | Claremont House 83 Church Road Bishopsworth BS13 8JU Bristol | Gbr | British | 77927160006 | |||||||||
| WATSON, Nicola Mary | Geschäftsführer | Oaktrow Farm Timberscombe TA24 7UF Minehead Somerset | England | British | 77927170001 | |||||||||
| WILKINSON, Linda Gay | Geschäftsführer | Beaconsfield Terrace Road Kensington W14 0PP London 10 England England | United Kingdom | British | 34375630002 | |||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||||||
| LONDON HEALTH AND FITNESS LIMITED | Geschäftsführer | Beaconsfield Terrace Road W14 0PP London 10 England |
| 153401220001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TWCL LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albion Ventures Limited | 15. Dez. 2017 | Kings Arms Yard EC2R 7AF London 1 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Albion Technology & General Vct Plc | 06. Apr. 2016 | Kings Arms Yard EC2R 7AF London 1 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr William James Peaker | 06. Apr. 2016 | 1 King's Arms Yard EC2R 7AF London C/O Albion Capital Group Llp United Kingdom | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Albion Capital Group Llp | 06. Apr. 2016 | Kings Arms Yard EC2R 7AF London 1 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat TWCL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 25. Juni 2014 Geliefert am 04. Juli 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The freehold property known as the land and buildings at broadwater and greenlands farm, walton lane weybridge, registered at the land registry under title number SY745769. Enthält eine Negativzusicherung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust debenture | Erstellt am 21. Nov. 2008 Geliefert am 04. Dez. 2008 | Teilweise erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust debenture | Erstellt am 13. Apr. 2007 Geliefert am 18. Apr. 2007 | Teilweise erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at broadwater farm and greenlands farm weybridge surrey t/n SY669748, S. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 08. Juli 2005 Geliefert am 18. Juli 2005 | Teilweise erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land k/a broadwater farm and greenlands farm weybridge surrey t/no SY669748,SY667828 and SY607710 together with all buildings and fixtures(including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon and therein. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust debenture | Erstellt am 05. Apr. 2005 Geliefert am 20. Apr. 2005 | Teilweise erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat TWCL LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0