LOGVALE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LOGVALE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04275100 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LOGVALE LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich LOGVALE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 30 City Road EC1Y 2AB London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LOGVALE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Nov. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LOGVALE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Aug. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Aug. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2021 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Aug. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2020 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Aug. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2019 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Seymour Smit als Sekretär am 31. Juli 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2018 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2017 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift 30 City Road London EC1Y 2AB verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2015 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 13 vollständig | 6 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 6 Seiten | MR04 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2015 bis 30. Nov. 2015 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LOGVALE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOKE, Paul Neville Rodney | Geschäftsführer | Stanny House Farm Iken IP12 2EY Woodbridge Suffolk | United Kingdom | British | 6777340001 | |||||
| KELLY, Crispin Noel | Geschäftsführer | Queensway W2 4QH London 71 United Kingdom | England | British | 2033150025 | |||||
| COOKE, Katherine Louise Harriet | Sekretär | Stanny House Farm Iken IP12 2EY Woodbridge Suffolk | British | 16243470001 | ||||||
| SMIT, Christopher Seymour | Sekretär | Queensway W2 4QH London 71 United Kingdom | British | 174356120002 | ||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
| COOKE, Katherine Louise Harriet | Geschäftsführer | Stanny House Farm Iken IP12 2EY Woodbridge Suffolk | United Kingdom | British | 16243470001 | |||||
| LONDON LAW SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LOGVALE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logvale Holding Company Limited | 06. Apr. 2016 | City Road EC1Y 2AB London 30 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat LOGVALE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of assignment | Erstellt am 09. Okt. 2007 Geliefert am 20. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights title benefits and interest to all moneys from time to time due owing or incurred under the leases. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Okt. 2007 Geliefert am 20. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the initial chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All properties listed in the schedule of the deed including all buildings erections and fixtures and fittings and fixed plant equipment and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Juli 2006 Geliefert am 28. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 6 blackwell gate darlington t/no DU164155. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Juli 2006 Geliefert am 28. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property known as 35 and 37 and 39 to 49A (odd) parkgate road london t/no's TGL197525 and SGL456067 and f/h property known as 35 and 37 parkgate road and part of the adjoining dock t/no TGL197526. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Juli 2006 Geliefert am 28. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 68 high street kings lynn norfolk t/no NK98650. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Juli 2006 Geliefert am 28. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property known as 18 cowcross street and sabian house 27 and 28 cowcross street and land lying to the north of cowcross street t/no's NGL804567 and NGL776132 and l/h property known as part of zinc house 19 to 25 cowcross street t/no NGL786159. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Juli 2006 Geliefert am 28. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment of rents | Erstellt am 06. Nov. 2001 Geliefert am 09. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All rents payable in respect of the f/h property k/a 18 cowcross street and sabin house 27/28 cowcross street EC1 and the l/h property k/a part zinc house, 19/26 cowcross street, london EC1. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment of rents | Erstellt am 06. Nov. 2001 Geliefert am 09. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All rents payable in respect of the f/h property k/a 39-49A parkgate road, london, SW11 and adjoining buildings. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 06. Nov. 2001 Geliefert am 09. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of a floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Nov. 2001 Geliefert am 09. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a 18 cowcross street and sabian house, 27/28 cowcross street and land at the rear of sabian house, 27/28 cowcross street, london, EC1, registered under part t/no NGL08816 and NGL776132 by way of assignment the goodwill and benefit of all licences. By way of floating charge all of its property and assets present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Nov. 2001 Geliefert am 09. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property k/a part zinc house, 19-26 cowcross street, london, EC1, t/no NGL786189 by way of assignment the goodwill and benefit of all licences. By way of floating charge all of its property and assets present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Nov. 2001 Geliefert am 09. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a 39-49A parkgate road, london, SW11, t/nos 177518, SGL456067 and SGL379713 by way of assignment the goodwill and benefit of all licences. By way of floating charge all of its property and assets present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0