LOGVALE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLOGVALE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04275100
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LOGVALE LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich LOGVALE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LOGVALE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Nov. 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für LOGVALE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Aug. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Aug. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2021

    13 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Aug. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2020

    13 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Aug. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2019

    13 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Christopher Seymour Smit als Sekretär am 31. Juli 2020

    1 SeitenTM02

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2018

    13 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2017

    15 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2016

    6 SeitenAA

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift 30 City Road London EC1Y 2AB verlegt

    1 SeitenAD04

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 22. Aug. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2015

    8 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    6 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    6 SeitenMR04

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2015 bis 30. Nov. 2015

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Aug. 2015

    Kapitalaufstellung am 27. Aug. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von LOGVALE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COOKE, Paul Neville Rodney
    Stanny House Farm Iken
    IP12 2EY Woodbridge
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Stanny House Farm Iken
    IP12 2EY Woodbridge
    Suffolk
    United KingdomBritish6777340001
    KELLY, Crispin Noel
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    United Kingdom
    EnglandBritish2033150025
    COOKE, Katherine Louise Harriet
    Stanny House Farm
    Iken
    IP12 2EY Woodbridge
    Suffolk
    Sekretär
    Stanny House Farm
    Iken
    IP12 2EY Woodbridge
    Suffolk
    British16243470001
    SMIT, Christopher Seymour
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    United Kingdom
    Sekretär
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    United Kingdom
    British174356120002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    COOKE, Katherine Louise Harriet
    Stanny House Farm
    Iken
    IP12 2EY Woodbridge
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Stanny House Farm
    Iken
    IP12 2EY Woodbridge
    Suffolk
    United KingdomBritish16243470001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LOGVALE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    City Road
    EC1Y 2AB London
    30
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    City Road
    EC1Y 2AB London
    30
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer6854101
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat LOGVALE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of assignment
    Erstellt am 09. Okt. 2007
    Geliefert am 20. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title benefits and interest to all moneys from time to time due owing or incurred under the leases. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Okt. 2007
    Geliefert am 20. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the initial chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All properties listed in the schedule of the deed including all buildings erections and fixtures and fittings and fixed plant equipment and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Juli 2006
    Geliefert am 28. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    6 blackwell gate darlington t/no DU164155. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Juli 2006
    Geliefert am 28. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 35 and 37 and 39 to 49A (odd) parkgate road london t/no's TGL197525 and SGL456067 and f/h property known as 35 and 37 parkgate road and part of the adjoining dock t/no TGL197526. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Juli 2006
    Geliefert am 28. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    68 high street kings lynn norfolk t/no NK98650. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Juli 2006
    Geliefert am 28. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 18 cowcross street and sabian house 27 and 28 cowcross street and land lying to the north of cowcross street t/no's NGL804567 and NGL776132 and l/h property known as part of zinc house 19 to 25 cowcross street t/no NGL786159. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Juli 2006
    Geliefert am 28. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of rents
    Erstellt am 06. Nov. 2001
    Geliefert am 09. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rents payable in respect of the f/h property k/a 18 cowcross street and sabin house 27/28 cowcross street EC1 and the l/h property k/a part zinc house, 19/26 cowcross street, london EC1.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of rents
    Erstellt am 06. Nov. 2001
    Geliefert am 09. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rents payable in respect of the f/h property k/a 39-49A parkgate road, london, SW11 and adjoining buildings.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 06. Nov. 2001
    Geliefert am 09. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of a floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Nov. 2001
    Geliefert am 09. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a 18 cowcross street and sabian house, 27/28 cowcross street and land at the rear of sabian house, 27/28 cowcross street, london, EC1, registered under part t/no NGL08816 and NGL776132 by way of assignment the goodwill and benefit of all licences. By way of floating charge all of its property and assets present and future.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Nov. 2001
    Geliefert am 09. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that property k/a part zinc house, 19-26 cowcross street, london, EC1, t/no NGL786189 by way of assignment the goodwill and benefit of all licences. By way of floating charge all of its property and assets present and future.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Nov. 2001
    Geliefert am 09. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a 39-49A parkgate road, london, SW11, t/nos 177518, SGL456067 and SGL379713 by way of assignment the goodwill and benefit of all licences. By way of floating charge all of its property and assets present and future.
    Berechtigte Personen
    • Halifax PLC
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0