GRANDDREAM LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGRANDDREAM LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04279481
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GRANDDREAM LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich GRANDDREAM LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Bdo Llp, 5 Temple Square
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GRANDDREAM LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für GRANDDREAM LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    18 SeitenLIQ14

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Bdo Llp 3 Hardman Street Spinningfields Manchester M3 3AT zum C/O Bdo Llp, 5 Temple Square Temple Street Liverpool L2 5RH am 03. Nov. 2021

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Nov. 2020

    12 SeitenLIQ03

    Tod eines Liquidators

    3 SeitenLIQ09

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Nov. 2019

    12 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Nov. 2018

    10 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Nov. 2017

    12 SeitenLIQ03

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:notice of release of former liquidator by secretary of state in mvl or cvl
    4 SeitenLIQ MISC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    18 SeitenLIQ10

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Nov. 2016

    9 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Nov. 2015

    9 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Nov. 2014

    11 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:court order - replacement of liquidator
    5 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * North House Fourth Floor 17 North John Street Liverpool Merseyside L2 5EA* am 21. Jan. 2014

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 29. Nov. 2013

    LRESEX

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Sept. 2013

    Kapitalaufstellung am 02. Sept. 2013

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Ernennung von Mr William Crocker als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Andrew Lovelady als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von GRANDDREAM LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CROCKER, William
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp, 5 Temple Square
    Sekretär
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp, 5 Temple Square
    179445290001
    SILVANO, Helen
    The Stables 1b Grange Park
    Maghull
    L31 3DP Liverpool
    Merseyside
    Sekretär
    The Stables 1b Grange Park
    Maghull
    L31 3DP Liverpool
    Merseyside
    British55343270002
    CROCKER, William Richard
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp, 5 Temple Square
    Geschäftsführer
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp, 5 Temple Square
    United KingdomBritish117141950001
    OWEN, Michael Barry
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    EnglandBritish69716360003
    HOLUBA, Kathleen
    196 Town Meadow Lane
    Moreton
    CH46 7SN Wirral
    Merseyside
    Sekretär
    196 Town Meadow Lane
    Moreton
    CH46 7SN Wirral
    Merseyside
    British92251710001
    LOVELADY, Andrew Robert
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    Sekretär
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    British41693730006
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BIRCHALL, Michael Maxwell
    Bawk House Farm
    Red Rock Haigh
    WN2 1LX Wigan
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Bawk House Farm
    Red Rock Haigh
    WN2 1LX Wigan
    Lancashire
    British7113830001
    BIRCHALL, Simon Christopher John
    Bawk House Farm
    Red Rock Haigh
    WN2 1LX Wigan
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Bawk House Farm
    Red Rock Haigh
    WN2 1LX Wigan
    Lancashire
    British64822060001
    BULLIVANT, Peter Wild
    Tudor Farm
    Kinnerton Road Dodleston
    CH4 9LP Chester
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Tudor Farm
    Kinnerton Road Dodleston
    CH4 9LP Chester
    Cheshire
    United KingdomBritish50290920002
    LOVELADY, Andrew Robert
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    Geschäftsführer
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    United KingdomBritish41693730006
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat GRANDDREAM LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2010
    Geliefert am 14. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor to any loan note holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of charged properties please refer to the form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Stephen George Laing as Lone Note Holder Security Trustee Pamela Jones as Loan Note Holder Security Trustee
    Transaktionen
    • 14. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Security accession deed
    Erstellt am 28. Sept. 2010
    Geliefert am 08. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Units 1-5 evolution park ewloe t/no CYM13955 (for further details of property charged please refer to form MG01) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Upside fee debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2010
    Geliefert am 08. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminter Bank PLC (Upside Fee Security Trustee)
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Dez. 2004
    Geliefert am 06. Jan. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land being angel suare shopping centre,angel lane,penrith t/no CU31894. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transaktionen
    • 06. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment
    Erstellt am 06. Nov. 2001
    Geliefert am 26. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by granddream limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of granddream limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company (group member) to the chargee as trustee for itself and the other lenders (trustee) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the occupational lease/s in respect of f/h land k/a angel square angel lane penrith.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgages (Life) Limited
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 06. Nov. 2001
    Geliefert am 23. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by granddream limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of granddream limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company (group member) to the chargee as trustee for itself and the other lenders (trustee) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a angel square shopping centre angel lane penrith together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any).
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgages (Life) Limited
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Nov. 2001
    Geliefert am 13. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility agreement of even date
    Kurze Angaben
    F/Hold land known as angel square shopping centre,angel lane,penrith; cu 31894.
    Berechtigte Personen
    • Ethel Austin Properties Holdings LTD
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat GRANDDREAM LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Nov. 2013Beginn der Liquidation
    28. Apr. 2022Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Edward Terence Kerr
    Pannell House, 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Praktiker
    Pannell House, 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Ian James Gould
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praktiker
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Lee Causer
    Bdo Llp Two Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praktiker
    Bdo Llp Two Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Kerry Bailey
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Jonathan David Newell
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0