AYLESBURY ONE LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAYLESBURY ONE LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04281570
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AYLESBURY ONE LTD?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich AYLESBURY ONE LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    52 Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AYLESBURY ONE LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für AYLESBURY ONE LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Ernennung von Will Gowanloch Westbrook als Direktor am 10. Juli 2012

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Krysto Archibald Milan Nikolic als Geschäftsführer am 10. Juli 2012

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    9 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Okt. 2011

    Kapitalaufstellung am 11. Okt. 2011

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    6 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    30 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    9 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Jonathan Robson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Russell Black als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Corin Leonard Thoday als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    6 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Lower Grosvenor Place London SW1W 0EN am 26. Feb. 2010

    2 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    7 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 175 30/04/2009
    RES13

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    14 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    6 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von AYLESBURY ONE LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DESAI, Falguni Rameshchandra
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    Sekretär
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    British77755390004
    FORD, Kenneth Charles
    43 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    Geschäftsführer
    43 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    EnglandBritishDirector52710005
    HAMILL, Luke
    Crystal Palace Road
    East Dulwich
    SE22 9JQ London
    227
    Geschäftsführer
    Crystal Palace Road
    East Dulwich
    SE22 9JQ London
    227
    United KingdomBritishAccountant114139360002
    JONES, Richard Peter
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    Geschäftsführer
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    EnglandBritishChartered Surveyor76584200002
    STAVELEY, Charles Andrew Rover
    Riverdale Gardens
    TW1 2BZ Twickenham
    17
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Riverdale Gardens
    TW1 2BZ Twickenham
    17
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant133771640001
    THODAY, Corin Leonard
    Norwich Road
    NR21 8AU Fakenham
    21
    Norfolk
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Norwich Road
    NR21 8AU Fakenham
    21
    Norfolk
    United Kingdom
    United KingdomBritishFund Manager138095630001
    WESTBROOK, Will Gowanloch
    St. Marys Grove
    W4 3LL London
    3
    Uk
    Geschäftsführer
    St. Marys Grove
    W4 3LL London
    3
    Uk
    UkBritishFund Manager170744070001
    OLSWANG COSEC LIMITED
    Third Floor
    90 Long Acre
    WC2E 9TT London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Third Floor
    90 Long Acre
    WC2E 9TT London
    900022270001
    BARBER, Martin
    8 Highfields Grove
    N6 6HN London
    Geschäftsführer
    8 Highfields Grove
    N6 6HN London
    BritishCompany Director35534320006
    BLACK, Russell Norman
    Meadow Way
    Boxmoor
    HP3 0AT Hemel Hempstead
    9
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Meadow Way
    Boxmoor
    HP3 0AT Hemel Hempstead
    9
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishInvestment Manager97983900003
    BOYLAND, Roger Michael
    Flat 5 Wellesley House
    Lower Sloane Street
    SW1W 8AL London
    Geschäftsführer
    Flat 5 Wellesley House
    Lower Sloane Street
    SW1W 8AL London
    BritishChartered Accountant33984480006
    CLARK, Philip John
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    Geschäftsführer
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    United KingdomBritishCompany Director101932350001
    CORAL, Lynda Sharon
    Westacre
    1a Sandy Lodge Road
    WD3 1LP Moor Park
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Westacre
    1a Sandy Lodge Road
    WD3 1LP Moor Park
    Hertfordshire
    BritishDirector Chartered Accountant34029880004
    FORD, Kenneth Charles
    43 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    Geschäftsführer
    43 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    EnglandBritishDirector And Chartered Surveyo52710005
    JONES, Richard Peter
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    Geschäftsführer
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    EnglandBritishChartered Surveyor76584200002
    LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritishInsurance Company Official62939740001
    LEWIS PRATT, Andrew
    61 Blandford Street
    W1U 7HR London
    Geschäftsführer
    61 Blandford Street
    W1U 7HR London
    BritishChartered Surveyor60050050008
    MANSLEY, Nicholas John Fermor
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    Geschäftsführer
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    EnglandBritishEconomist73817060002
    NELL, Philip John Payton
    Bury Lodge
    Bury Lane Elmdon
    CB11 4NQ Saffron Walden
    Essex
    Geschäftsführer
    Bury Lodge
    Bury Lane Elmdon
    CB11 4NQ Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritishFund Manager105566370001
    NIKOLIC, Krysto Archibald Milan
    47-51 Gillingham Street
    SW1V 1HS London
    Flat 2 Sovereign Court
    Geschäftsführer
    47-51 Gillingham Street
    SW1V 1HS London
    Flat 2 Sovereign Court
    UkBritishFund Manager138589710001
    PULLEN, Xavier
    65 Studdridge Street
    SW6 3SL London
    Geschäftsführer
    65 Studdridge Street
    SW6 3SL London
    EnglandBritishCompany Director78912170008
    ROBSON, Jonathan
    151 Gladstone Road
    Wimbledon
    SW19 1QS London
    Geschäftsführer
    151 Gladstone Road
    Wimbledon
    SW19 1QS London
    United KingdomBritishChartered Surveyor109313040002
    SUNNUCKS, William D'Urban
    East Gores Farm
    Salmons Lane
    CO6 1RZ Coggeshall
    Essex
    Geschäftsführer
    East Gores Farm
    Salmons Lane
    CO6 1RZ Coggeshall
    Essex
    EnglandBritishChart Accountant32866350001
    WOMACK, Ian Bryan
    6 Southwood Lawn Road
    Highgate
    N6 5SF London
    Geschäftsführer
    6 Southwood Lawn Road
    Highgate
    N6 5SF London
    EnglandBritishChartered Surveyor33902000006
    OLSWANG DIRECTORS 1 LIMITED
    Third Floor
    90 Long Acre
    WC2E 9TT London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Third Floor
    90 Long Acre
    WC2E 9TT London
    900022260001
    OLSWANG DIRECTORS 2 LIMITED
    Third Floor
    90 Long Acre
    WC2E 9TT London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Third Floor
    90 Long Acre
    WC2E 9TT London
    900022250001

    Hat AYLESBURY ONE LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 08. Okt. 2008
    Geliefert am 20. Okt. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and ato to the finance parties of any kind on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    90 cambridge street aylesbury t/no. BM200062, 104 cambridge street aylesbury t/no. BM139294, 96 cambridge street aylesbury t/no. BM201323, 98 cambridge street aylesbury by way of fixed charge the additional properties, all the plant, machinery and fixtures and fittings of the mortgagor, all furniture, furnishings, equipment, tools and other chattels see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent for the Banks and as Security Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Apr. 2006
    Geliefert am 12. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 100 cambridge street, aylesbury t/no BM306376. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Agent)
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Apr. 2006
    Geliefert am 12. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 102 cambridge street aylesbury t/n BM305341 or any part of it fixed charge all plant machinery fixtures and fittings furniture furnishings equipment tools and other chattels goodwill and the proceeds of any insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent for the Banks and as a Security Trustee for the Financeparties (The Agent)
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Apr. 2006
    Geliefert am 12. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H cambridge close retail park and other land at cambridge street aylesbury t/n BM306052 or any part of it fixed charge all plant machinery fixtures and fittings furniture furnishings equipment tools and other chattels goodwill and the proceeds of any insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent for the Banks and as a Security Trustee for the Financeparties (The Agent)
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Apr. 2006
    Geliefert am 12. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H the county arms public house 124 cambridge street aylesbury t/n BM225202 or any part of it all plant machinery fixtures and fittings furniture furnishings equipment tools and other chattels the goodwill and the proceeds of any insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent for the Banks and as a Security Trustee for the Financeparties (The Agent)
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 2003
    Geliefert am 30. Dez. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on cambridge close retail park cambridge street aylesbury f/h t/n's BM240811 and BM207396 and all that area of land forming part of the land and buildings k/a fire authority headquarters cambridge street aylesbury. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent for the Banks and as Security Trustee for the Financeparties
    Transaktionen
    • 30. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Jan. 2002
    Geliefert am 21. Jan. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H cambridge close retail park, cambridge street, aylesbury t/no. BM161895. By way of fixed charge the plant machinery, fixtures, fittings, furniture and equipment at the property. The goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance from time to time affecting the property or charged assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Plcas Agent for the Banks and as Security Trustee for the Finance Parties (The "Agent")
    Transaktionen
    • 21. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 03. Jan. 2002
    Geliefert am 21. Jan. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Plcas Agent for the Banks and as Security Trustee for the Finance Parties (The "Agent")
    Transaktionen
    • 21. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Nov. 2001
    Geliefert am 20. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a cambridge close retail park aylesbury t/no: BM161895. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 19. Sept. 2001
    Geliefert am 25. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the deed
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a cambridge close retail park aylesbury t/ n BM161895. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0