AYLESBURY ONE LTD
Überblick
Unternehmensname | AYLESBURY ONE LTD |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04281570 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AYLESBURY ONE LTD?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich AYLESBURY ONE LTD?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 52 Grosvenor Gardens SW1W 0AU London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AYLESBURY ONE LTD?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AYLESBURY ONE LTD?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Will Gowanloch Westbrook als Direktor am 10. Juli 2012 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Krysto Archibald Milan Nikolic als Geschäftsführer am 10. Juli 2012 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollst ändiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 30 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Robson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Russell Black als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Corin Leonard Thoday als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Lower Grosvenor Place London SW1W 0EN am 26. Feb. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 14 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AYLESBURY ONE LTD?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESAI, Falguni Rameshchandra | Sekretär | Apartment 108 20 Palace Street SW1E 5BA London | British | 77755390004 | ||||||
FORD, Kenneth Charles | Geschäftsführer | 43 Hans Place SW1X 0JZ London | England | British | Director | 52710005 | ||||
HAMILL, Luke | Geschäftsführer | Crystal Palace Road East Dulwich SE22 9JQ London 227 | United Kingdom | British | Accountant | 114139360002 | ||||
JONES, Richard Peter | Geschäftsführer | Tudor House 11 Lower Street CM24 8LN Stansted | England | British | Chartered Surveyor | 76584200002 | ||||
STAVELEY, Charles Andrew Rover | Geschäftsführer | Riverdale Gardens TW1 2BZ Twickenham 17 United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 133771640001 | ||||
THODAY, Corin Leonard | Geschäftsführer | Norwich Road NR21 8AU Fakenham 21 Norfolk United Kingdom | United Kingdom | British | Fund Manager | 138095630001 | ||||
WESTBROOK, Will Gowanloch | Geschäftsführer | St. Marys Grove W4 3LL London 3 Uk | Uk | British | Fund Manager | 170744070001 | ||||
OLSWANG COSEC LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Third Floor 90 Long Acre WC2E 9TT London | 900022270001 | |||||||
BARBER, Martin | Geschäftsführer | 8 Highfields Grove N6 6HN London | British | Company Director | 35534320006 | |||||
BLACK, Russell Norman | Geschäftsführer | Meadow Way Boxmoor HP3 0AT Hemel Hempstead 9 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Investment Manager | 97983900003 | ||||
BOYLAND, Roger Michael | Geschäftsführer | Flat 5 Wellesley House Lower Sloane Street SW1W 8AL London | British | Chartered Accountant | 33984480006 | |||||
CLARK, Philip John | Geschäftsführer | 26 Bourne Avenue Southgate N14 6PD London | United Kingdom | British | Company Director | 101932350001 | ||||
CORAL, Lynda Sharon | Geschäftsführer | Westacre 1a Sandy Lodge Road WD3 1LP Moor Park Hertfordshire | British | Director Chartered Accountant | 34029880004 | |||||
FORD, Kenneth Charles | Geschäftsführer | 43 Hans Place SW1X 0JZ London | England | British | Director And Chartered Surveyo | 52710005 | ||||
JONES, Richard Peter | Geschäftsführer | Tudor House 11 Lower Street CM24 8LN Stansted | England | British | Chartered Surveyor | 76584200002 | ||||
LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr | Geschäftsführer | High House Ranworth Road Hemblington NR13 4PJ Norwich Norfolk | United Kingdom | British | Insurance Company Official | 62939740001 | ||||
LEWIS PRATT, Andrew | Geschäftsführer | 61 Blandford Street W1U 7HR London | British | Chartered Surveyor | 60050050008 | |||||
MANSLEY, Nicholas John Fermor | Geschäftsführer | 4 Willis Road CB1 2AQ Cambridge | England | British | Economist | 73817060002 | ||||
NELL, Philip John Payton | Geschäftsführer | Bury Lodge Bury Lane Elmdon CB11 4NQ Saffron Walden Essex | England | British | Fund Manager | 105566370001 | ||||
NIKOLIC, Krysto Archibald Milan | Geschäftsführer | 47-51 Gillingham Street SW1V 1HS London Flat 2 Sovereign Court | Uk | British | Fund Manager | 138589710001 | ||||
PULLEN, Xavier | Geschäftsführer | 65 Studdridge Street SW6 3SL London | England | British | Company Director | 78912170008 | ||||
ROBSON, Jonathan | Geschäftsführer | 151 Gladstone Road Wimbledon SW19 1QS London | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 109313040002 | ||||
SUNNUCKS, William D'Urban | Geschäftsführer | East Gores Farm Salmons Lane CO6 1RZ Coggeshall Essex | England | British | Chart Accountant | 32866350001 | ||||
WOMACK, Ian Bryan | Geschäftsführer | 6 Southwood Lawn Road Highgate N6 5SF London | England | British | Chartered Surveyor | 33902000006 | ||||
OLSWANG DIRECTORS 1 LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Third Floor 90 Long Acre WC2E 9TT London | 900022260001 | |||||||
OLSWANG DIRECTORS 2 LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Third Floor 90 Long Acre WC2E 9TT London | 900022250001 |
Hat AYLESBURY ONE LTD Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 08. Okt. 2008 Geliefert am 20. Okt. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and ato to the finance parties of any kind on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 90 cambridge street aylesbury t/no. BM200062, 104 cambridge street aylesbury t/no. BM139294, 96 cambridge street aylesbury t/no. BM201323, 98 cambridge street aylesbury by way of fixed charge the additional properties, all the plant, machinery and fixtures and fittings of the mortgagor, all furniture, furnishings, equipment, tools and other chattels see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 04. Apr. 2006 Geliefert am 12. Apr. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 100 cambridge street, aylesbury t/no BM306376. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 04. Apr. 2006 Geliefert am 12. Apr. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 102 cambridge street aylesbury t/n BM305341 or any part of it fixed charge all plant machinery fixtures and fittings furniture furnishings equipment tools and other chattels goodwill and the proceeds of any insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 04. Apr. 2006 Geliefert am 12. Apr. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H cambridge close retail park and other land at cambridge street aylesbury t/n BM306052 or any part of it fixed charge all plant machinery fixtures and fittings furniture furnishings equipment tools and other chattels goodwill and the proceeds of any insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 04. Apr. 2006 Geliefert am 12. Apr. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H the county arms public house 124 cambridge street aylesbury t/n BM225202 or any part of it all plant machinery fixtures and fittings furniture furnishings equipment tools and other chattels the goodwill and the proceeds of any insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 22. Dez. 2003 Geliefert am 30. Dez. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on cambridge close retail park cambridge street aylesbury f/h t/n's BM240811 and BM207396 and all that area of land forming part of the land and buildings k/a fire authority headquarters cambridge street aylesbury. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Jan. 2002 Geliefert am 21. Jan. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H cambridge close retail park, cambridge street, aylesbury t/no. BM161895. By way of fixed charge the plant machinery, fixtures, fittings, furniture and equipment at the property. The goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance from time to time affecting the property or charged assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 03. Jan. 2002 Geliefert am 21. Jan. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 20. Nov. 2001 Geliefert am 20. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a cambridge close retail park aylesbury t/no: BM161895. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 19. Sept. 2001 Geliefert am 25. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the deed | |
Kurze Angaben The f/h property k/a cambridge close retail park aylesbury t/ n BM161895. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0