RED FUNNEL FERRIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | RED FUNNEL FERRIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04281782 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RED FUNNEL FERRIES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich RED FUNNEL FERRIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RED FUNNEL FERRIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| GREENSOURCE LIMITED | 05. Sept. 2001 | 05. Sept. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RED FUNNEL FERRIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RED FUNNEL FERRIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Notification of Falcon Acquisitions Limited as a person with significant control on 31. Jan. 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Red Funnel Group (Holdings) Limited as a person with significant control on 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Red Funnel Group (Holdings) Limited as a person with significant control on 31. Jan. 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Red Funnel Group Limited as a person with significant control on 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 042817820005 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 31. Jan. 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Edward Arthur Wilson als Geschäftsführer am 08. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Francis Campbell als Geschäftsführer am 08. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Charles John Gore Hazelwood als Geschäftsführer am 08. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Mark Moorhouse Green als Geschäftsführer am 11. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Arthur Murray Carter als Geschäftsführer am 11. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Mark Slawson als Geschäftsführer am 11. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Wallace Inch als Geschäftsführer am 12. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lee Richard Hudson als Geschäftsführer am 12. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Shirley Ann Anderson als Geschäftsführer am 13. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 042817820004 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 042817820005, erstellt am 20. Juli 2017 | 17 Seiten | MR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RED FUNNEL FERRIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGE, Kevin Alan | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 186130710001 | |||||
| WINTER, Paul Richard | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 132752850001 | |||||
| HUME, Kate | Sekretär | Broadwalk House 5 Appold Street EC2A 2HA London | British | 78063700002 | ||||||
| MILES, Graham John | Sekretär | Willow Lodge Sway Road SO42 7SG Brockenhurst Hampshire | British | 8125620001 | ||||||
| SHEARD, John Paul | Sekretär | 42 Serpentine Road PO16 7EB Fareham Hampshire | British | 61554710001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ANDERSON, Shirley Ann | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | United Kingdom | British | 254667910001 | |||||
| BLAND, Christopher Donald Jack | Geschäftsführer | Yafford House PO30 3LH Shorwell Isle Of Wight | United Kingdom | British | 8125610001 | |||||
| BRADBURY, Kenton Edward | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 147513860001 | |||||
| CAMPBELL, Michael Francis | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | Canada | Canadian | 235365510001 | |||||
| CARTER, Arthur Murray | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | United Kingdom | British | 127391460001 | |||||
| COOPER, James Nigel Shelley | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 265561970001 | |||||
| DELLACHA, Maria Georgina | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 174489750001 | |||||
| DOCHERTY, Thomas James | Geschäftsführer | Garden Cottage Fritham Court Fritham SO43 7HH Lyndhurst Hampshire | England | British | 83269560002 | |||||
| DOMINY, Jacqueline | Geschäftsführer | Woodlands 46 Telegraph Road West End SO30 3EX Southampton Hampshire | United Kingdom | British | 206004200001 | |||||
| EDWARDS, Keith David William | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | United Kingdom | British | 114681720002 | |||||
| FULFORD, James Simon Richard | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | United Kingdom | British | 137465940001 | |||||
| GLASS, Olive Helen | Geschäftsführer | 55 Ashdale Park RG40 3QS Wokingham Berkshire | British | 38249750003 | ||||||
| GORDON, Gavin James | Geschäftsführer | Flat 8 The Design Works 93-99 Goswell Road EC1V 7ER London | British | 90600880001 | ||||||
| GREEN, Jonathan Mark Moorhouse | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | United Kingdom | British | 127407610001 | |||||
| HAZELWOOD, Charles John Gore | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 111535480002 | |||||
| HELMORE, Max David Charles | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 174349030001 | |||||
| HETHERINGTON, Colin Crawford | Geschäftsführer | Woodpeckers 64 Baring Road PO31 8DJ Cowes Isle Of Wight | British | 103607280004 | ||||||
| HUDSON, Lee Richard | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | United Kingdom | British | 156861680001 | |||||
| INCH, John Wallace | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 222917320001 | |||||
| MILES, Graham John | Geschäftsführer | Willow Lodge Sway Road SO42 7SG Brockenhurst Hampshire | British | 8125620001 | ||||||
| NELSON, Stephen Keith James | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | United Kingdom | British | 91708030001 | |||||
| RAYNER, William John | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | United Kingdom | British | 99969530001 | |||||
| SCHUMACHER, Bernd | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | German | 169583030001 | |||||
| SCOTT, Richard Antony Cargill | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 107002130001 | |||||
| SLAWSON, James Mark | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | England | British | 191539160001 | |||||
| WHYTE, Alistair Morrison | Geschäftsführer | 11 Stoney Lane SO22 6DN Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 8125600001 | |||||
| WILSON, Edward Arthur | Geschäftsführer | 12 Bugle Street Southampton SO14 2JY Hampshire | United Kingdom | British | 214718430001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei RED FUNNEL FERRIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Funnel Group (Holdings) Limited | 31. Jan. 2018 | Bugle Street SO14 2JY Southampton 12 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Falcon Acquisitions Limited | 31. Jan. 2018 | Bugle Street SO14 2JY Southampton 12 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Red Funnel Group Limited | 06. Apr. 2016 | Bugle Street SO14 2JY Southampton 12 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat RED FUNNEL FERRIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 20. Juli 2017 Geliefert am 27. Juli 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung All land (except for restricted land) as listed in schedule 1 together with all buildings fixtures and fixed plant and machinery at any time thereon, intellectual property (except for any restricted ip), and the specified intellectual property owned by the company, in each case as specified (and defined) in the deed of accession and charge registered by this form MR01. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 08. Juli 2016 Geliefert am 12. Juli 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Okt. 2007 Geliefert am 01. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Red funnel deed of charge | Erstellt am 21. Dez. 2001 Geliefert am 02. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings being k/a the red funnel ferry terminal car parks and car marshalling areas east cowes isle of wight t/nos IW49024, IW49023, IW49041, IW42695, IW29058 all f/h land and buildings at fountain quay west cowes t/no IW49025 f/h land and buldings at 10,12,14 and 16 bugle street southampton t/no HP596087 (for full details of all property charged see form 395) together with fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Okt. 2001 Geliefert am 26. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present or future obligations of the obligors (as defined) to the chargee under the finance documents and the mezzanine finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0