RAVENSTOCK MSG LIMITED
Überblick
Unternehmensname | RAVENSTOCK MSG LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04283040 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RAVENSTOCK MSG LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich RAVENSTOCK MSG LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Ravenstock House 28 Falcon Court Preston Farm Business Park TS18 3TX Stockton-On-Tees |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RAVENSTOCK MSG LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
FREEPEAK LIMITED | 06. Sept. 2001 | 06. Sept. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RAVENSTOCK MSG LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RAVENSTOCK MSG LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 7 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Sept. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Christopher Miner als Geschäftsführer am 16. Juni 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Hezron Lopez als Direktor am 16. Juni 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Steven Dickinson als Direktor am 15. März 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Andrew Thompson als Geschäftsführer am 13. März 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 7 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Timothy Boswell als Direktor am 30. Aug. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Bradley Soultz als Direktor am 30. Aug. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Van Welch als Geschäftsführer am 30. Aug. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Kelly Williams als Geschäftsführer am 30. Aug. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 7 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Erfüllung der Belastung 042830400011 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 042830400013 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 042830400012 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Eintragung der Belastung 042830400014, erstellt am 01. Juli 2020 | 68 Seiten | MR01 | ||
Ernennung von Kelly Williams als Direktor am 29. Jan. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Andrew Thompson als Direktor am 29. Jan. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Erik Olsson als Geschäftsführer am 29. Jan. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von RAVENSTOCK MSG LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSWELL, Timothy | Geschäftsführer | 28 Falcon Court Preston Farm Business Park TS18 3TX Stockton-On-Tees Ravenstock House | United States | American | Director | 287361540001 | ||||||||
DICKINSON, Steven | Geschäftsführer | 28 Falcon Court Preston Farm Business Park TS18 3TX Stockton-On-Tees Ravenstock House | England | British | Finance Director | 294129760001 | ||||||||
LOPEZ, Hezron | Geschäftsführer | 28 Falcon Court Preston Farm Business Park TS18 3TX Stockton-On-Tees Ravenstock House | United States | American | Chief Legal & Compliance Officer | 297208110001 | ||||||||
PARKES, Graeme Bryan | Geschäftsführer | 28 Falcon Court Preston Farm Business Park TS18 3TX Stockton-On-Tees Ravenstock House | United States | American | Chief Information Officer | 243214530001 | ||||||||
SOULTZ, Bradley | Geschäftsführer | 28 Falcon Court Preston Farm Business Park TS18 3TX Stockton-On-Tees Ravenstock House | United States | American | Director | 287361420001 | ||||||||
HALCHISHAK, Ronald | Sekretär | The Stables Wynyard TS22 5QQ Billingham 16 Cleveland United Kingdom | American | Secretary | 137171890001 | |||||||||
MORGAN, Christopher David | Sekretär | 28 Falcon Court Preston Farm Business Park TS18 3TX Stockton-On-Tees Ravenstock House | 191945810001 | |||||||||||
ROBERTSON, James Stirling | Sekretär | 16510 Academia Drive CA 91436 Encino California Usa | American | Senior Vice President | 69784390001 | |||||||||
VILLEGAS, Allan A | Sekretär | 2182 E Dudley Street CA 91104 Pasadena Usa | British | 127472710001 | ||||||||||
WILSON, Christopher | Sekretär | 1026 Fairview Drive FOREIGN La Canada California 91011 United States | American | General Councel | 91823060001 | |||||||||
CREMORNE NOMINEES LIMITED | Sekretär | 32-38 Station Road SL9 8EL Gerrards Cross Collins House Buckinghamshire United Kingdom |
| 3329890001 | ||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
BUNGER, Steven | Geschäftsführer | West Trovita Place 85226 Chandler 6134 Arizona Usa | Usa | American | Director | 112243740001 | ||||||||
DONOVAN, Michael | Geschäftsführer | 54 West 82nd Street, Apt 5 New York 10024 Usa | American | Director | 116940390001 | |||||||||
FUNK, Mark Edwin | Geschäftsführer | West Clarendon Avenue Phoenix 60 Arizona 85013 United States | Usa | American | Executive Vp & Cfo | 137207360002 | ||||||||
HALCHISHAK, Ronald | Geschäftsführer | The Stables Wynyard TS22 5QQ Billingham 16 Cleveland United Kingdom | United Kingdom | American | Director | 137171890001 | ||||||||
KEELEY, Deborah | Geschäftsführer | W Citation Lane 85284 Tempe 366 Arizona Usa | Usa | American | Director | 133387330002 | ||||||||
MELLIFONT, Kevin Michael | Geschäftsführer | 148 Smoke Rise Road Bedminster New Jersey Nj 07921 Usa | American | Chief Operating Officer | 70935090001 | |||||||||
MINER, Christopher | Geschäftsführer | E Laguna Azul 85209 Meza 10437 Arizona United States | United States | American | Director | 133585260001 | ||||||||
MORGAN, Christopher David | Geschäftsführer | 28 Falcon Court Preston Farm Business Park TS18 3TX Stockton-On-Tees Ravenstock House | United Kingdom | British | Managing Director | 84676900001 | ||||||||
MOSS, Neil | Geschäftsführer | 103 Norbreck Close Great Sankey WA5 2SJ Warrington Cheshire | England | British | Managing Director | 82032760001 | ||||||||
OLSSON, Erik | Geschäftsführer | 28 Falcon Court Preston Farm Business Park TS18 3TX Stockton-On-Tees Ravenstock House Uk | United States | American | Chief Executive | 177710530001 | ||||||||
ROBERTSON, James Stirling | Geschäftsführer | 16510 Academia Drive CA 91436 Encino California Usa | United States | American | Senior Vice President | 69784390001 | ||||||||
SLINGERLAND, Robert | Geschäftsführer | 4844 Petit Avenue Encino California 91436 United States | American | Chief Financial Officer | 91823200001 | |||||||||
SWANI, Sanjay | Geschäftsführer | 33 East End Avenue, Apt 5-C New York New York 10028-7007 Usa | American | Chairman Of The Board | 116940480001 | |||||||||
THOMPSON, Andrew | Geschäftsführer | 28 Falcon Court Preston Farm Business Park TS18 3TX Stockton-On-Tees Ravenstock House | England | British | Managing Director | 266700000001 | ||||||||
TRACHTENBERG, Lawrence | Geschäftsführer | N Scottsdale Road 85253 Scottsdale 5646 Arizona Uk | American | Director | 133387210001 | |||||||||
VALENTA, Ronald Frank | Geschäftsführer | 5200 Jessen Drive FOREIGN La Canada California Ca91011 Usa | United States | American | Company President | 76325060001 | ||||||||
WAUGAMAN, Douglas | Geschäftsführer | 25802 North Chisum Trail Scottsdale Arizona 85255 United States | American | President Ceo | 101550740001 | |||||||||
WELCH, Van | Geschäftsführer | 28 Falcon Court Preston Farm Business Park TS18 3TX Stockton-On-Tees Ravenstock House | United States | American | Chief Financial Officer | 237406990001 | ||||||||
WILLIAMS, Kelly | Geschäftsführer | 28 Falcon Court Preston Farm Business Park TS18 3TX Stockton-On-Tees Ravenstock House | United States | American | Chief Executive | 266700350001 | ||||||||
CREMORNE NOMINEES NO 2 LIMITED | Geschäftsführer | Collins House 32-38 Station Road SL9 8EL Gerrards Cross Buckinghamshire | 51054270003 | |||||||||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei RAVENSTOCK MSG LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobile Mini Uk Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | 28 Falcon Court Preston Farm Industrial Estate TS18 3TX Stockton-On-Tees Ravenstock House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat RAVENSTOCK MSG LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 01. Juli 2020 Geliefert am 02. Juli 2020 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Not applicable. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 22. März 2019 Geliefert am 28. März 2019 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Not applicable. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 14. Dez. 2015 Geliefert am 31. Dez. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 10. Dez. 2014 Geliefert am 15. Dez. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 22. Feb. 2012 Geliefert am 01. März 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. Juni 2008 Geliefert am 10. Juli 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company, any UK credit party and a UK borrower to the chargee, an agent, any lender or any affiliate of any lender and any UK issuing lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of properties charged, please refer to form 395, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 01. Aug. 2006 Geliefert am 21. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any subsidiary guarantor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Dez. 2005 Geliefert am 06. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any UK borrower to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Dez. 2003 Geliefert am 05. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any beneficiary by the UK borrower under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of deposit | Erstellt am 15. Okt. 2002 Geliefert am 23. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All deposits now and in the future credited to account designation 23743344 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 09. Aug. 2002 Geliefert am 13. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from mobile storage (U.K.) limited and by the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the north side of north road bridgend industrial estate bridgend f/h t/no: WA842086. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental debenture | Erstellt am 07. Juni 2002 Geliefert am 13. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage north road, bridgend, mid glamorgan t/n WA84286, riverside avenue west, lawford, essex t/n EX432052, the leasehold property known as tees offshore base, dockside ride, southbank, middlesbrough, cleveland TS6 6UZ (for further details of property charged see part v of schedule to 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of deposit | Erstellt am 28. Jan. 2002 Geliefert am 30. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All deposits credited to account designation 23723785 and any deposit or account of any other currency description or designation. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture between the company (formerly known as freepeak limited) and the bank of nova scotia for itself and as agent and security trustee for the UK lenders (as defined) | Erstellt am 15. Nov. 2001 Geliefert am 20. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee whether under the finance documents the guarantee or on any other account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0