BRIGHTS CHEMISTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRIGHTS CHEMISTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04284210
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRIGHTS CHEMISTS LIMITED?

    • (9999) /

    Wo befindet sich BRIGHTS CHEMISTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRIGHTS CHEMISTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRIGHTS CHEMISTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    4 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011

    3 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Christopher James Giles als Geschäftsführer am 05. Sept. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Mark Francis Muller als Direktor am 05. Sept. 2011

    3 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Sept. 2011

    Kapitalaufstellung am 06. Sept. 2011

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Ernennung von David Charles Geoffrey Foster als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von David Charles Geoffrey Foster als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Mark Muller als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Patricia Kennerley als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Aylward als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mark Muller als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Christopher James Giles als Direktor

    3 SeitenAP01

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    5 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    16 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 10. Mai 2007

    8 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von BRIGHTS CHEMISTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Sekretär
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    British150377060001
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Geschäftsführer
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritish52040210004
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    Geschäftsführer
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    United KingdomBritish63620010002
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    Sekretär
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    British63620010002
    PATEL, Nishma
    85 Harborne Road
    Edgbaston
    B15 3HG Birmingham
    Sekretär
    85 Harborne Road
    Edgbaston
    B15 3HG Birmingham
    British78273430002
    JPCORS LIMITED
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    900001430001
    AYLWARD, Christopher David
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell
    Woking
    Geschäftsführer
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell
    Woking
    United KingdomBritish59741430002
    GILES, Christopher James
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    Geschäftsführer
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    EnglandBritish149729660001
    KENNERLEY, Patricia Diane
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    Geschäftsführer
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    Great BritainBritish110727230002
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish63620010002
    PATEL, Bipin
    85 Harborne Road
    Edgbaston
    B15 3HG Birmingham
    Geschäftsführer
    85 Harborne Road
    Edgbaston
    B15 3HG Birmingham
    United KingdomBritish78273460002
    PATEL, Nishma
    85 Harborne Road
    Edgbaston
    B15 3HG Birmingham
    Geschäftsführer
    85 Harborne Road
    Edgbaston
    B15 3HG Birmingham
    United KingdomBritish78273430002
    JPCORD LIMITED
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    900001420001

    Hat BRIGHTS CHEMISTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage
    Erstellt am 27. Nov. 2006
    Geliefert am 05. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 hartlebury road oldbury west midlands. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 20. Apr. 2006
    Geliefert am 29. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 255 lyndon road solihull west midlands t/n WM88487. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 24. Nov. 2003
    Geliefert am 04. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 1 hartlebury road oldbury. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Okt. 2003
    Geliefert am 13. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 29. Okt. 2003
    Geliefert am 01. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as or being 48, three shire oak road smethwick birmingham t/no WM793586. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 29. Okt. 2003
    Geliefert am 01. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as or being shop 4A, flat 4 and garage, coniston way, nuneaton t/no WK376315. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 29. Okt. 2003
    Geliefert am 01. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as or being 1 middlemore road, northfield t/no WM651916. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Okt. 2003
    Geliefert am 28. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The properties being 1 middlemore road northfield B3 3UD, 1 hartlebury road oldbury B69 1DF, 4A coniston way, nuneaton CV11 6DG, 255 lyndon road solihull B92 7QP, 48 three shires oak road smethwick B67 5BU. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aah Pharmaceuticals Limited, Barclay Pharmaceuticals Limited and Farillon Limited
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Juli 2003
    Geliefert am 11. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 hartlebury road oldbury sandwell west midlands. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. März 2003
    Geliefert am 01. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    255 lyndon road sheldon solihull west midlands B92 7QP. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Feb. 2003
    Geliefert am 05. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    48 three shires oak road,smethwick,west midlands B67 5BS. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Okt. 2002
    Geliefert am 23. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 middlemore road northfield birmingham B31 3UD. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Aug. 2002
    Geliefert am 13. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Shop 4A flat 4 and garage coniston way nuneaton warwickshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Mai 2002
    Geliefert am 31. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0