SOUTHERN CROSS CARE CENTRES LIMITED

SOUTHERN CROSS CARE CENTRES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSOUTHERN CROSS CARE CENTRES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04285217
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SOUTHERN CROSS CARE CENTRES LIMITED?

    • (8514) /

    Wo befindet sich SOUTHERN CROSS CARE CENTRES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SOUTHERN CROSS CARE CENTRES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HIGHFIELD CARE CENTRES LIMITED11. Okt. 200111. Okt. 2001
    SOUTHELM LIMITED11. Sept. 200111. Sept. 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SOUTHERN CROSS CARE CENTRES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für SOUTHERN CROSS CARE CENTRES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012

    1 SeitenTM02

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    6 Seiten1.4

    Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 17. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    4 Seiten1.1

    Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Sept. 2011

    Kapitalaufstellung am 15. Sept. 2011

    • Kapital: GBP 1,800,002
    SH01

    Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    34 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Explanatory statemtn to sole member 14/05/2010
    RES13

    Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2009

    25 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Andrew Smith am 07. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David Smith als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Kamma Foulkes als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Janette Malham als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von SOUTHERN CROSS CARE CENTRES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    JOYCE, Meriel Lucy Ann
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    Sekretär
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    British16385330010
    KAUL, Sheila
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    Sekretär
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    British70194600001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158305780001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    BRIAN REID LTD.
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    Bevollmächtigter Sekretär
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    900018660001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    FARMER, Nicholas John
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish124228290001
    FEARN, Lynn
    Elmwood Drive
    DE55 7QJ Alfreton
    24
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Elmwood Drive
    DE55 7QJ Alfreton
    24
    Derbyshire
    United KingdomBritish130867640001
    FINNIS, Pam
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish133719530001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    FOULKES, Kamma
    17 Lower Castle Street
    NP7 5EE Abergavenny
    Monmouthshire
    Geschäftsführer
    17 Lower Castle Street
    NP7 5EE Abergavenny
    Monmouthshire
    United KingdomBritish111188390002
    GEE, Andrew Anthony Edward
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    Geschäftsführer
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    EnglandBritish93592160001
    GROOMBRIDGE, Kevin John
    51 Old Croft Road
    ST17 0NL Stafford
    Geschäftsführer
    51 Old Croft Road
    ST17 0NL Stafford
    EnglandBritish105722880001
    HAINES, Ellen
    8 Jackdaw Lane
    WR9 7HE Droitwich
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    8 Jackdaw Lane
    WR9 7HE Droitwich
    Worcestershire
    British89071020002
    HEAPS, Ann
    8 Oakwood Close
    BL8 1DD Bury
    Lancashire
    Geschäftsführer
    8 Oakwood Close
    BL8 1DD Bury
    Lancashire
    British124068050001
    JOYCE, Anthony
    Gibliston Farmhouse
    Colinsburgh
    KY9 1JS Leven
    Fife
    Geschäftsführer
    Gibliston Farmhouse
    Colinsburgh
    KY9 1JS Leven
    Fife
    ScotlandBritish95693160002
    JOYCE, Martin Patrick
    La Rue A
    St Peter Port
    GY1 1QG Guernsey
    Geschäftsführer
    La Rue A
    St Peter Port
    GY1 1QG Guernsey
    United KingdomBritish27130160009
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Geschäftsführer
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MALHAM, Janette
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish91088900004
    MALHAM, Janette
    The Limekilns
    9a Elm Grove
    TS26 8LZ Hartlepool
    Geschäftsführer
    The Limekilns
    9a Elm Grove
    TS26 8LZ Hartlepool
    EnglandBritish91088900003
    MALHAM, Janette
    Jesmond The Parade
    Grange Road
    TS26 0DY Hartlepoole
    Geschäftsführer
    Jesmond The Parade
    Grange Road
    TS26 0DY Hartlepoole
    British91088900001
    MCKEEVER, Pauline Ann
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    Geschäftsführer
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    BritainBritish91521130001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    Geschäftsführer
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    British26177180002
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Geschäftsführer
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    POYNTON, Ellen
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    Geschäftsführer
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    United KingdomBritish89071020004
    PRESTON, Mary
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish124068010001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Geschäftsführer
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Geschäftsführer
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001

    Hat SOUTHERN CROSS CARE CENTRES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Rent deposit deed
    Erstellt am 27. Jan. 2003
    Geliefert am 30. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The tenant with full title guarantee charges to the landlord: 1. the deposit, 2. all interest, 3. the deposit account, and 4. the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 3 Limited (The Landlord)
    Transaktionen
    • 30. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 29. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The deposit, all interest the deposit account and the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 29. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 29. Jan. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The tenant with full title guarantee charges to the landlord: 1. the deposit; 2. all interest; 3. the deposit account; and 4. the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    Transaktionen
    • 29. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2002
    Geliefert am 27. Dez. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right title estate and other interest of the company in l/h premises situate at crown meadow nursing home toll end road tipton dudley DY4 0HB. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 27. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 19. Dez. 2002
    Geliefert am 24. Dez. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit all interest the deposit account and the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 18. Dez. 2002
    Geliefert am 24. Dez. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 14. Okt. 2002
    Geliefert am 23. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The leasehold premises situate at cedar court and magna nursing homes 27-29 long street wigston leicestershire LE18 3BP. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 14. Okt. 2002
    Geliefert am 23. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold premises situate at the willows nursing and residental home 89 london road hinckley leicestershire LE10 1HH. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 14. Okt. 2002
    Geliefert am 23. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The leasehold premises situate at hinckley park nursing home 67 london road hinckley leicestershire LE10 1HH. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 14. Okt. 2002
    Geliefert am 17. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 17. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 14. Okt. 2002
    Geliefert am 17. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit, all interest, the deposit acount and the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 17. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 14. Okt. 2002
    Geliefert am 17. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit; all interest; the deposit account and the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 17. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 18. Sept. 2002
    Geliefert am 27. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Including l/hold premises at huntercombe hall nursing home,huntercombe place,nuffield,henley on thames,oxfordshire RG9 5SB. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 18. Sept. 2002
    Geliefert am 27. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Including l/hold premises at ashbourne nursing and residential home,lightwood rd,dudley,west midlands DY1 2RS. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.9 Limited
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 18. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The tenant with full title guarantee charges to the landlord 1. the deposit 2. all interest 3. the deposit account and 4. the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 18. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The tenant with full guarantee charges to the landlord the deposit, all interest, the deposit account; and the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 9 Limited
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 11. Sept. 2002
    Geliefert am 12. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest as tenant in and to the deposit, all interest the deposit account and the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 09. Sept. 2002
    Geliefert am 12. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises situate at lobley hill nursing and residential home 54 high street wordsley stourbridge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 07. Aug. 2002
    Geliefert am 10. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The tenant with full title guarantee charges to the landlord: the deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 07. Aug. 2002
    Geliefert am 09. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The leasehold property known as the beeches nursing home beech road armthorpe doncaster DN3 2DY together with all buildings fixtures and fittings thereon fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 02. Juli 2002
    Geliefert am 12. Juli 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The tenant with full title guarantee charges to the landlord, the deposit being the sum of £18,000.00 and all interest, the deposit account being an interest bearing account specifically designated "ashgrove nursing and residential home deposit account" and the deposit balance meaning the amount from timne to time standing to the credit of the deposit account.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transaktionen
    • 12. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 02. Juli 2002
    Geliefert am 11. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit all interest the deposit account and the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 11. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 02. Juli 2002
    Geliefert am 10. Juli 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit all interest the deposit account and the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.8 Limited
    Transaktionen
    • 10. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 02. Juli 2002
    Geliefert am 05. Juli 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the l/h property k/a ashgrove nursing and residential home, dudley wood road, netherton, west midlands, DY2 0DX, together with all buildings, structures, fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings but excluding landlords's fixtures) and fixed plant and machinery to the extent therein or thereon;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.10 Limited (Nhps)
    Transaktionen
    • 05. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 02. Juli 2002
    Geliefert am 05. Juli 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Including l/h premises situate at pennwood lodge nursing home, wotton road, kingswood, wotton-under-edge, gloucester, GL12 8RA by way of legal mortgage. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 8 Limited
    Transaktionen
    • 05. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)

    Hat SOUTHERN CROSS CARE CENTRES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Juni 2012Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    20. Aug. 2012Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praktiker
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0