ALEXANDRA MILLS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ALEXANDRA MILLS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04295356 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ALEXANDRA MILLS LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich ALEXANDRA MILLS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 29 Park Square West LS1 2PQ Leeds |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ALEXANDRA MILLS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ALEXANDER MILLS LIMITED | 27. Sept. 2001 | 27. Sept. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ALEXANDRA MILLS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ALEXANDRA MILLS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 17 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Mai 2017 | 14 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Mai 2015 | 9 Seiten | 4.68 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Mai 2016 | 10 Seiten | 4.68 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Paylings 7 the Office Camous Red Hall Court Paragon Wakefield West Yorkshire WF1 2UY zum 29 Park Square West Leeds LS1 2PQ am 24. März 2015 | 3 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 10 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 4 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2013 bis 31. März 2014 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 10 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 10 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 11 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 11 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 36 Bond Street Wakefield West Yorkshire WF1 2QP* am 08. Sept. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||
Löschung von Aktien. Kapitalaufstellung am 18. Feb. 2010
| 4 Seiten | SH06 | ||||||||||||||
Eigenkapitalrückkauf. | 3 Seiten | SH03 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 19 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Verschiedenes Directors statement and aud report re section 714 ca 2006 ( repurchase of shares) | 3 Seiten | MISC | ||||||||||||||
legacy | 10 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ALEXANDRA MILLS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURNS, Ann | Sekretär | Walton Grange Cottage 201 Shay Lane Walton WF2 6NW Wakefield West Yorkshire | British | 4381230003 | ||||||
| ARMSTRONG, Keiron Barry | Geschäftsführer | Knightcross Newstead Abbey Park Ravenshead NG15 8GE Nottingham | England | British | 32536070003 | |||||
| ARMSTRONG, Terry Owen | Geschäftsführer | Drummond Lodge 72 Highfield Road Nuthall NG16 1BP Nottingham | United Kingdom | British | 62815220002 | |||||
| BRAIDE, William Gordon | Geschäftsführer | Sandal Lodge Walton Lane Sandal WF2 6NG Wakefield West Yorkshire | England | British | 78542290001 | |||||
| HARRISON, David Neil | Geschäftsführer | Brackendale Cottage 71 Church Street WF5 9DT Ossett West Yorkshire | England | British | 95843170001 | |||||
| MARZANO, Giuliano | Geschäftsführer | Burton House Newcastle Circus The Park NG7 1BJ Nottingham | United Kingdom | British | 10079150003 | |||||
| RUDDIMAN, David Anthony Peter | Geschäftsführer | Fixby Lodge Fixby Park HD2 2ER Huddersfield West Yorkshire | England | British | 15132270002 | |||||
| HARRISON, David Neil | Sekretär | Brackendale Cottage 71 Church Street WF5 9DT Ossett West Yorkshire | British | 95843170001 | ||||||
| YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 51066720001 | |||||||
| BATTYE, Stephen Paul | Geschäftsführer | Gothic House Park Road WF13 4LR Dewsbury West Yorkshire | United Kingdom | British | 9282480001 | |||||
| FOX, Brian Nigel | Geschäftsführer | Apartment 27 Boothroyds Apartments Halifax Road WF13 2AS Dewsbury | British | 80084030001 | ||||||
| YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | 12 York Place LS1 2DS Leeds | 51066670001 |
Hat ALEXANDRA MILLS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Erstellt am 28. Sept. 2004 Geliefert am 05. Okt. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 28. Sept. 2004 Geliefert am 05. Okt. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Alexandra mills alexandra road batley t/n WYK54930,. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 28. Nov. 2003 Geliefert am 02. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property being alexandra mills alexandra road batley west yorkshire. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Sept. 2003 Geliefert am 06. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ALEXANDRA MILLS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0