AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04301069 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED?
- Nicht-Lebensversicherung (65120) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Aon Centre The Leadenhall Building 122 Leadenhall Street EC3V 4AN London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
LORICA CONSULTING LIMITED | 15. Juli 2005 | 15. Juli 2005 |
HEALTH FOR INDUSTRY LIMITED | 25. Jan. 2002 | 25. Jan. 2002 |
CONTACTBASE LIMITED | 09. Okt. 2001 | 09. Okt. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Charles Battle als Geschäftsführer am 21. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christine Marie Williams als Geschäftsführer am 19. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Alistair Patrick Boyd als Direktor am 19. Sept. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Paul Arthur Hogwood als Direktor am 23. Aug. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tobin Mathew Murphy-Coles als Geschäftsführer am 01. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Neville Herbert als Geschäftsführer am 19. Juli 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. Nov. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Charles Battle am 13. Juli 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 8 Devonshire Square London EC2M 4PL England zum 10 Devonshire Square London EC2M 4YP geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 8 Devonshire Square London EC2M 4PL verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Cosec 2000 Limited am 13. Juli 2015 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christine Marie Williams am 13. Juli 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für James Neville Herbert am 13. Juli 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSEC 2000 LIMITED | Sekretär | 122 Leadenhall Street EC3V 4AN London The Aon Centre, The Leadenhall Building United Kingdom |
| 152185840001 | ||||||||||
BOYD, Alistair Patrick | Geschäftsführer | The Leadenhall Building 122 Leadenhall Street EC3V 4AN London The Aon Centre | United Kingdom | British | Accountant | 214544820001 | ||||||||
HOGWOOD, Paul Arthur | Geschäftsführer | The Leadenhall Building 122 Leadenhall Street EC3V 4AN London The Aon Centre | United Kingdom | British | Company Secretary | 7453920005 | ||||||||
BUHAGIAR, Bryan | Bevollmächtigter Sekretär | 14 Fernbank Close Walderslade ME5 9NH Chatham Kent | British | 900011210001 | ||||||||||
GODSELL, Jeanette Louise | Sekretär | 30 St Michaels Road GU47 8HE Sandhurst Berkshire | British | Insurance Broking | 75623730001 | |||||||||
KEILL, Tracy Elizabeth | Sekretär | 'Verandah House' 8 Pokiok Road Smith's Fl05 Bermuda | British | 127332980001 | ||||||||||
MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre | Sekretär | 39 Lynwood Grove BR6 0BD Orpington Kent | British | 75598460002 | ||||||||||
NEWELL, Mark Verity | Sekretär | Moffat Pains Hill Limpsfield Chart RH8 0RG Oxted Surrey | British | Director | 77855100001 | |||||||||
PEAKE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Prospect Place SN1 3LJ Swindon Hardwick House Wiltshire |
| 55731680011 | ||||||||||
BATTLE, David Charles | Geschäftsführer | The Leadenhall Building 122 Leadenhall Street EC3V 4AN London The Aon Centre United Kingdom | England | British | Company Director | 111477590002 | ||||||||
BEAUMONT, Peter Stuart | Geschäftsführer | Badgers Hollow Rowhills GU9 9AU Farnham Surrey | British | Finance Director | 78770280001 | |||||||||
BIBBY, John | Geschäftsführer | Plovers Tudor Close RH20 2E Pulborough West Sussex | British | Company Director | 27995540003 | |||||||||
BRADBURY, Susan Patricia | Geschäftsführer | Causeway Foot Rochdale Road Pole Moor Outlane HD3 3FQ Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 40471660002 | ||||||||
BRADLEY, Stephen Michael | Geschäftsführer | Little London Cottage 61-62 High Street BA12 0EB Heytesbury Wiltshire | England | British | Insurance Broking | 75623610001 | ||||||||
BUHAGIAR, Susan | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14 Fernbank Close Walderslade ME5 9NH Chatham Kent | United Kingdom | British | 900011200001 | |||||||||
CARTER, Patrick Robert | Geschäftsführer | Rue De Peuplier 7-9 FOREIGN 1000 Brussels Belgium | British | Consultant | 81585030001 | |||||||||
CLARIDGE-WARE, Christopher Maurice | Geschäftsführer | Fireball Hill SL5 9PJ Sunningdale The Grange Berkshire | United Kingdom | British | Director | 5828350004 | ||||||||
CONNELL, Alistair James | Geschäftsführer | Devonshire Square EC2M 4PL London 8 United Kingdom | England | British | None | 154274870002 | ||||||||
COOMBER, Karen Maria | Geschäftsführer | Moorhams Avenue Hatch Warren RG22 4YG Basingstoke 7 Hampshire | England | British | Compliance Director | 100159270003 | ||||||||
EDMANDS, David James Rosewall | Geschäftsführer | 16 Kings Chase TN24 0LQ Ashford Kent | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 118042260001 | ||||||||
HERBERT, James Neville | Geschäftsführer | The Leadenhall Building 122 Leadenhall Street EC3V 4AN London The Aon Centre United Kingdom | United Kingdom | British | None | 164559940002 | ||||||||
HODES, Jonathan | Geschäftsführer | 81 Lauderdale Mansions Lauderdale Road W9 1LX London | British | Accountant | 79523100001 | |||||||||
JACKSON, John David, Mr. | Geschäftsführer | Prospect Place SN1 3LJ Swindon Hardwick House | United Kingdom | British | Director | 166242060001 | ||||||||
JAMES, Philip William Henry | Geschäftsführer | Swan Building 26 Victoria Street ML3 0LE Hamilton Lanarkshire Bermuda | British | Insurance Broker1 | 33901640005 | |||||||||
KEILL, Tracy Elizabeth | Geschäftsführer | 'Verandah House' 8 Pokiok Road Smith's Fl05 Bermuda | British | Insurance Executive | 127332980001 | |||||||||
KING, Michael Henry | Geschäftsführer | 45 Leicester Road Wanstead E11 2DW London | British | Company Director | 14395670002 | |||||||||
KLAIRE, Clare Elizabeth | Geschäftsführer | 1 Chalk Dell Cottages Chawton Park Road, Chawton GU34 1SW Alton Hampshire | United Kingdom | British | Insurance Broking | 75623670001 | ||||||||
MARLEY, Nicholas James | Geschäftsführer | 6 The Brambles Woodside SW19 7AY London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 113304050001 | ||||||||
MARLEY, Nicholas James | Geschäftsführer | 2 Nursery Road Merton SW19 3BT London | British | Chartered Accountant | 81585110001 | |||||||||
MORLEY, James | Geschäftsführer | Virginia House St Marys Road SL5 9JE Ascot Berkshire | United Kingdom | United Kingdom | Chartered Accountant | 13374700001 | ||||||||
MORLEY HAM, Stephen Richard | Geschäftsführer | Golf Course Way Jolly Harbour St Mary's 319b Antigua | British | Director | 80334700004 | |||||||||
MURPHY-COLES, Tobin Mathew | Geschäftsführer | The Leadenhall Building 122 Leadenhall Street EC3V 4AN London The Aon Centre United Kingdom | England | British | Director | 161141640001 | ||||||||
MURRAY, Alastair Neil | Geschäftsführer | B303, Gilbert Scott Building Scott Avenue SW15 3ST Putney | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 124855970001 | ||||||||
NICHOL, Duncan Kirkbride, Sir | Geschäftsführer | 1 Pipers Close CH60 9LJ Heswall Merseyside | United Kingdom | British | Director | 85618250001 | ||||||||
NICHOL, Duncan Kirkbride, Sir | Geschäftsführer | 1 Pipers Close CH60 9LJ Heswall Merseyside | United Kingdom | British | Company Director | 85618250001 |
Hat AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A composite debenture | Erstellt am 13. Dez. 2012 Geliefert am 22. Dez. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A composite debenture | Erstellt am 14. Nov. 2008 Geliefert am 18. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company to the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 28. Feb. 2007 Geliefert am 15. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge all shares in any group company,all of its investments now or subsequently belonging to it held by an. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 10. Feb. 2006 Geliefert am 02. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 04. Juli 2005 Geliefert am 09. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £15,862.50 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The sum of £15,862.50. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 01. Mai 2004 Geliefert am 11. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben By way of fixed equitable charge all the goodwill and uncalled capital the securities the insurances the rents the fixed plant and equipment by way of first floating charge all those assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over shares | Erstellt am 01. Mai 2004 Geliefert am 11. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the charged property to the chargee and upon an enforcement eventall dividends distributions, distributions in specie interest and other monies payable in respect of the charged property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over dividends and shares | Erstellt am 30. Okt. 2003 Geliefert am 01. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,296,450.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The charged shares , any shares or securities issued by way of redemption, bonus, rights, consolidation, sub-division, preference, option or otherwise in respect of the charged shares and all dividends, distributions and other monies payable in respect of charged shares. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over dividends and shares | Erstellt am 11. Sept. 2003 Geliefert am 02. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,296,450.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben By way of a fixed charge the shares and any shares or securities issued by way of redemption, bonus, rights, consolidation, sub-division, preference, option or otherwise in respect of the charged shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rental deposit deed | Erstellt am 08. Okt. 2002 Geliefert am 16. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £42,750.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Its interest in the deposit account (as defined in the deed) and all money withdrawn from the deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0