CITY MOTOR HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CITY MOTOR HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04301565 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CITY MOTOR HOLDINGS LIMITED?
- Verkauf von Neuwagen und leichten Nutzfahrzeugen (45111) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Verkauf von Gebrauchtwagen und leichten Nutzfahrzeugen (45112) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (45200) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Einzelhandel mit Kraftfahrzeugteilen und -zubehör (45320) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich CITY MOTOR HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o KPMG LLP Arlington Business Park Theale RG7 4SD Reading |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CITY MOTOR HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BLAKEDEW 328 LIMITED | 09. Okt. 2001 | 09. Okt. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CITY MOTOR HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CITY MOTOR HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 26 Seiten | AM23 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 26 Seiten | AM10 | ||||||||||
Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 8 | 5 Seiten | MR05 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 20. März 2017 | 29 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 043015650014 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 36 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 7 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Houndmills Autoplaza Aldermaston Road Basingstoke Hampshire RG21 6YL United Kingdom zum C/O Kpmg Llp Arlington Business Park Theale Reading RG7 4SD am 25. Okt. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Ernennung von Condatis Limited als Direktor am 12. Sept. 2016 | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Mark Poole Head Office Aldermaston Road South Basingstoke Hampshire RG21 6YL zum Houndmills Autoplaza Aldermaston Road Basingstoke Hampshire RG21 6YL am 22. Aug. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Richard Poole als Geschäftsführer am 31. Mai 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher William Robert Hayden als Direktor am 01. Apr. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 043015650014, erstellt am 15. Jan. 2016 | 25 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Hemlock als Geschäftsführer am 15. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Eintragung der Belastung 043015650013, erstellt am 22. Mai 2015 | 16 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 32 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CITY MOTOR HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJP SECRETARIES LIMITED | Sekretär | High Street KT7 0SR Thames Ditton 2 Ac Court Surrey |
| 61999120002 | ||||||||||
| HAYDEN, Christopher William Robert | Geschäftsführer | c/o Kpmg Llp Arlington Business Park Theale RG7 4SD Reading | United Kingdom | British | 208268570001 | |||||||||
| CONDATIS LIMITED | Geschäftsführer | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 5th Floor United Kingdom |
| 170163900001 | ||||||||||
| OBS 24 LLP | Geschäftsführer | Old Bond Street W1S 4AW London 5th Floor 24 |
| 170559870001 | ||||||||||
| ELVIDGE, Christopher Edric David | Sekretär | 80 Beestonfields Drive NG9 3TD Bramcote Nottinghamshire | British | 91249380001 | ||||||||||
| MORTIMER, Andrew Paul James | Sekretär | Northweald Lane KT2 5GL Kingston Upon Thames 23 Surrey United Kingdom | British | 134750630001 | ||||||||||
| POOLE, Mark Richard | Sekretär | c/o Mark Poole Aldermaston Road South RG21 6YL Basingstoke Head Office Hampshire United Kingdom | 163651000001 | |||||||||||
| SMITH, David Peter Ansley | Sekretär | Copped Hall Barn Okehurst Lane RH14 9HR Billinghurst West Sussex | British | 2541030004 | ||||||||||
| WICKINS, Michael Anthony | Sekretär | Hazelwood Lodge Hennock TQ139PU Bovey Tracey Devon | British | 114468860007 | ||||||||||
| BLAKELAW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Harbour Court Compass Road North Harbour PO6 4ST Portsmouth Hampshire | 900001990001 | |||||||||||
| BORGAS, Peter Martin | Geschäftsführer | Faubourg Du Lac 31 Neuchatel 2000 Switzerland | Switzerland | Belgian | 124283100002 | |||||||||
| ELVIDGE, Christopher Edric David | Geschäftsführer | 80 Beestonfields Drive NG9 3TD Bramcote Nottinghamshire | British | 91249380001 | ||||||||||
| HEMLOCK, Stephen | Geschäftsführer | c/o Mark Poole Aldermaston Road South RG21 6YL Basingstoke Head Office Hampshire United Kingdom | Uk | British | 100191970001 | |||||||||
| MARTIN, Adrian Howard | Geschäftsführer | Kimpton Park Kimpton SG4 8EG Hitchin Hertfordshire | United Kingdom | British | 22288420001 | |||||||||
| MORGAN, Derek Anthony | Geschäftsführer | The Homestead Shenley Church End MK5 6DJ Milton Keynes | United Kingdom | British | 51781140002 | |||||||||
| POOLE, Mark Richard | Geschäftsführer | c/o Mark Poole Aldermaston Road South RG21 6YL Basingstoke Head Office Hampshire United Kingdom | England | British | 174874030001 | |||||||||
| RUSSELL, David Wallace | Geschäftsführer | Montgomery House Montgomery Road PO9 2RH Havant Hampshire | England | British | 62852230001 | |||||||||
| SAMPSON, Barry Hugh Dunbar | Geschäftsführer | Bosham Hoe Bosham PO18 8ET Chichester Waterside West Sussex United Kingdom | England | British | 53247190009 | |||||||||
| SMITH, David Peter Ansley | Geschäftsführer | Copped Hall Barn Okehurst Lane RH14 9HR Billinghurst West Sussex | British | 2541030004 | ||||||||||
| SPAETT, Christian Rainer | Geschäftsführer | West Lodge Ashwell TA19 9DY Ilminster Somerset | German | 79239080002 | ||||||||||
| WALKER, Gavin Robert | Geschäftsführer | Highcliffe Close EX12 2QA Seaton Highcliff Lodge Devon United Kingdom | United Kingdom | British | 128424740001 | |||||||||
| WALKER, Gavin Robert | Geschäftsführer | Highcliffe Close EX12 2QA Seaton Highclyffe Lodge Devon | United Kingdom | British | 128424740001 | |||||||||
| WATSON, Kevin Terry | Geschäftsführer | 3 Sea Drive Felpham PO22 7NB Bognor Regis West Sussex | United Kingdom | British | 115409100001 | |||||||||
| WICKINS, Anthony John | Geschäftsführer | Valdoe House East Lavant PO18 8AW Chichester West Sussex | United Kingdom | British | 2541040001 | |||||||||
| WICKINS, Michael Anthony | Geschäftsführer | Hazelwood Lodge Hennock TQ139PU Bovey Tracey Devon | England | British | 114468860007 | |||||||||
| BLAKELAW DIRECTOR SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Harbour Court Compass Road North Harbour PO6 4ST Portsmouth Hampshire | 900001980001 |
Hat CITY MOTOR HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 15. Jan. 2016 Geliefert am 15. Jan. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 22. Mai 2015 Geliefert am 22. Mai 2015 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 25. Apr. 2013 Geliefert am 08. Mai 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Aug. 2009 Geliefert am 06. Aug. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Aug. 2009 Geliefert am 05. Aug. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 03. Aug. 2009 Geliefert am 05. Aug. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Aug. 2005 Geliefert am 20. Aug. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Juli 2005 Geliefert am 27. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Juli 2005 Geliefert am 27. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Juli 2005 Geliefert am 27. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Jan. 2004 Geliefert am 10. Jan. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Sept. 2003 Geliefert am 19. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 15. Jan. 2003 Geliefert am 28. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed charge the entire legal and beneficial interest in 500,000 redeemable shares of £1.00 each in the capital of ashtenne city limited and all stocks, shares, warrants or other securities, rights, dividends, monies, interest or other property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security of the assignment of loan notes | Erstellt am 09. Jan. 2003 Geliefert am 28. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Assigns £500,000 loan notes issued by ashtenne city limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CITY MOTOR HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0