CURO GROUP (ALBION) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCURO GROUP (ALBION) LIMITED
    UnternehmensstatusUmwandlung / Auflösung
    RechtsformUmwandlung / Auflösung
    Unternehmensnummer 04302179
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CURO GROUP (ALBION) LIMITED?

    • Aktivitäten anderer Mitgliederorganisationen n.a. (94990) / Sonstige Dienstleistungsbereiche

    Wo befindet sich CURO GROUP (ALBION) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CURO GROUP (ALBION) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SOMER HOUSING GROUP LIMITED10. Okt. 200110. Okt. 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CURO GROUP (ALBION) LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. März 2019
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Dez. 2019
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für CURO GROUP (ALBION) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verschiedenes

    Combined form b/z convert to rs
    1 SeitenMISC

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Convert to rs 16/11/2018
    RES13

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2018

    54 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Victor Da Cunha als Sekretär am 20. Apr. 2018

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Ms Katherine Gullon als Sekretär am 20. Apr. 2018

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Emily Wilson als Sekretär am 20. Apr. 2018

    1 SeitenTM02

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2017

    59 SeitenAA

    Ernennung von Emily Wilson als Sekretär am 20. Nov. 2017

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Philippa Armstrong als Sekretär am 21. Nov. 2017

    1 SeitenTM02

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Nathan Stillwell am 08. Sept. 2017

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Mr Simon David Gibbs als Direktor am 20. Feb. 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Dermot Gerard Courtier als Geschäftsführer am 20. Feb. 2017

    1 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Approval to appoint executive directors 07/11/2016
    RES13

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    23 SeitenMA

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2016

    68 SeitenAA

    Ernennung von Mr Christopher John Wilson als Direktor am 21. Nov. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Victor Manuel Silva Da Cunha als Direktor am 21. Nov. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr David Ashmore als Direktor am 17. Okt. 2016

    2 SeitenAP01

    legacy

    SeitenANNOTATION

    Ernennung von Ms Elaine Barnes als Direktor am 04. Okt. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Rick De Blaby als Direktor am 17. Okt. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Brian Tapp als Geschäftsführer am 17. Okt. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Martin William Nurse als Geschäftsführer am 17. Okt. 2016

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von CURO GROUP (ALBION) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GULLON, Katherine
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    Sekretär
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    245679730001
    ASHMORE, David
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    Geschäftsführer
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    EnglandBritish217179970001
    BARNES, Elaine
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    Geschäftsführer
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    United KingdomBritish103202570001
    DA CUNHA, Victor Manuel Silva
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    Geschäftsführer
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    EnglandBritish104048750002
    DE BLABY, Rick
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    Geschäftsführer
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    United KingdomBritish216828360001
    GIBBS, Simon David
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    Geschäftsführer
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    EnglandBritish223221690001
    POTTER, Elizabeth Anne
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    Geschäftsführer
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    EnglandBritish172516960001
    STILLWELL, Richard Nathan
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    Geschäftsführer
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    EnglandBritish80064790001
    WILSON, Christopher John
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    Geschäftsführer
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    EnglandBritish219228600001
    ARMSTRONG, Philippa
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    Sekretär
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    201723040001
    ARMSTRONG, Philippa
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    Sekretär
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    British108400480001
    BROOKE, Rosalind
    4 Southview
    Timsbury
    BA2 0LZ Bath
    Sekretär
    4 Southview
    Timsbury
    BA2 0LZ Bath
    British16839520002
    CLARKE, David
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    Sekretär
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    188800610001
    CLARKE, David
    Lower Bristol Road
    BA2 1EP Bath
    The Maltings River Place
    Sekretär
    Lower Bristol Road
    BA2 1EP Bath
    The Maltings River Place
    British151390140001
    DA CUNHA, Victor
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    Sekretär
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    194531300001
    DA CUNHA, Victor
    Lower Bristol Road
    BA2 1EP Bath
    The Maltings River Place
    Uk
    Sekretär
    Lower Bristol Road
    BA2 1EP Bath
    The Maltings River Place
    Uk
    British159387250001
    HALL, Diane Patricia
    33 Orchard Way
    North Bradley
    BA14 0SU Trowbridge
    Wiltshire
    Sekretär
    33 Orchard Way
    North Bradley
    BA14 0SU Trowbridge
    Wiltshire
    English38198930003
    HALL, Diane Patricia
    33 Orchard Way
    North Bradley
    BA14 0SU Trowbridge
    Wiltshire
    Sekretär
    33 Orchard Way
    North Bradley
    BA14 0SU Trowbridge
    Wiltshire
    English38198930003
    HASTINGS, Richard
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    Sekretär
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    188797000001
    HILL, Alexandra Abigail
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    Sekretär
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    194531090001
    INFANTE, Brenda
    River Place
    Lower Bristol Road
    BA2 1EP Bath
    The Maltings
    Uk
    Sekretär
    River Place
    Lower Bristol Road
    BA2 1EP Bath
    The Maltings
    Uk
    British177383710001
    MOXHAM, Maria
    2 Pinetum Close
    SN10 5EW Devizes
    Wiltshire
    Sekretär
    2 Pinetum Close
    SN10 5EW Devizes
    Wiltshire
    British100167950001
    SMITHERS, Tonia Lorraine
    Fosseway
    Midsomer Norton
    BA3 4AU Radstock
    1 Little Orchard
    Somerset
    Sekretär
    Fosseway
    Midsomer Norton
    BA3 4AU Radstock
    1 Little Orchard
    Somerset
    British128054140001
    WATSON, Steve
    Masters Farm
    Well Road
    BA3 4SD Emborough
    Somerset
    Sekretär
    Masters Farm
    Well Road
    BA3 4SD Emborough
    Somerset
    British124975860001
    WILSON, Emily
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    Sekretär
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    240507780001
    APPLEYARD, Robin Alan, Cllr
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    Geschäftsführer
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    United KingdomBritish157193430001
    BADER, David John
    Groves Road
    NP20 3SP Newport
    20
    Gwent
    Geschäftsführer
    Groves Road
    NP20 3SP Newport
    20
    Gwent
    United KingdomBritish84821210001
    BATTERSBY, Tom
    Grosvenor Villas
    BA1 6QL Bath
    10
    Avon
    Geschäftsführer
    Grosvenor Villas
    BA1 6QL Bath
    10
    Avon
    United KingdomBritish133460880002
    BLIGH, Juliet Elizabeth
    14 Clyde Road
    Redland
    BS6 6RP Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    14 Clyde Road
    Redland
    BS6 6RP Bristol
    Avon
    EnglandBritish108807800001
    BLIGH, Juliet Elizabeth
    14 Clyde Road
    Redland
    BS6 6RP Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    14 Clyde Road
    Redland
    BS6 6RP Bristol
    Avon
    EnglandBritish108807800001
    BRISCOE, Graham Owen
    Lower Bristol Road
    BA2 1EP Bath
    The Maltings River Place
    Geschäftsführer
    Lower Bristol Road
    BA2 1EP Bath
    The Maltings River Place
    EnglandBritish17350840001
    CONNOR, Margaret Jacqueline
    Ashcroft Avenue
    Keynsham
    BS31 2EX Bristol
    21
    Avon
    Geschäftsführer
    Ashcroft Avenue
    Keynsham
    BS31 2EX Bristol
    21
    Avon
    UkBritish80039210002
    COURTIER, Dermot Gerard
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    Geschäftsführer
    The Maltings
    River Place
    BA2 1EP Lower Bristol Road
    Bath
    United KingdomBritish134345640001
    DAVEY, Joanna Mary
    2 Glenview
    Titlands Lane Wookey Hole
    BA5 1BD Wells
    Somerset
    Geschäftsführer
    2 Glenview
    Titlands Lane Wookey Hole
    BA5 1BD Wells
    Somerset
    British59582530001
    DAVEY, Joanna Mary
    2 Glenview
    Titlands Lane Wookey Hole
    BA5 1BD Wells
    Somerset
    Geschäftsführer
    2 Glenview
    Titlands Lane Wookey Hole
    BA5 1BD Wells
    Somerset
    British59582530001

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für CURO GROUP (ALBION) LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    10. Okt. 2016Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Hat CURO GROUP (ALBION) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Shg debenture
    Erstellt am 12. Juli 2004
    Geliefert am 21. Juli 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security trustee, any nominee, delegate or agent thereof or any receiver, under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all rights under or in respect of the documents, all rights, title and interest in and to the documents, by way of first floating charge the undertaking and assets.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited as Trustee for the Senior Beneficiaries
    Transaktionen
    • 21. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0