CURO GROUP (ALBION) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CURO GROUP (ALBION) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Umwandlung / Auflösung |
| Rechtsform | Umwandlung / Auflösung |
| Unternehmensnummer | 04302179 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CURO GROUP (ALBION) LIMITED?
- Aktivitäten anderer Mitgliederorganisationen n.a. (94990) / Sonstige Dienstleistungsbereiche
Wo befindet sich CURO GROUP (ALBION) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CURO GROUP (ALBION) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SOMER HOUSING GROUP LIMITED | 10. Okt. 2001 | 10. Okt. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CURO GROUP (ALBION) LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. März 2019 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Dez. 2019 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CURO GROUP (ALBION) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschiedenes Combined form b/z convert to rs | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2018 | 54 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Victor Da Cunha als Sekretär am 20. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Ms Katherine Gullon als Sekretär am 20. Apr. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Emily Wilson als Sekretär am 20. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2017 | 59 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Emily Wilson als Sekretär am 20. Nov. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philippa Armstrong als Sekretär am 21. Nov. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Nathan Stillwell am 08. Sept. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon David Gibbs als Direktor am 20. Feb. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dermot Gerard Courtier als Geschäftsführer am 20. Feb. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 23 Seiten | MA | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2016 | 68 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher John Wilson als Direktor am 21. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Victor Manuel Silva Da Cunha als Direktor am 21. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Ashmore als Direktor am 17. Okt. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | Seiten | ANNOTATION | ||||||||||
Ernennung von Ms Elaine Barnes als Direktor am 04. Okt. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Rick De Blaby als Direktor am 17. Okt. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Tapp als Geschäftsführer am 17. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin William Nurse als Geschäftsführer am 17. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CURO GROUP (ALBION) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GULLON, Katherine | Sekretär | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | 245679730001 | |||||||
| ASHMORE, David | Geschäftsführer | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | England | British | 217179970001 | |||||
| BARNES, Elaine | Geschäftsführer | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | United Kingdom | British | 103202570001 | |||||
| DA CUNHA, Victor Manuel Silva | Geschäftsführer | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | England | British | 104048750002 | |||||
| DE BLABY, Rick | Geschäftsführer | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | United Kingdom | British | 216828360001 | |||||
| GIBBS, Simon David | Geschäftsführer | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | England | British | 223221690001 | |||||
| POTTER, Elizabeth Anne | Geschäftsführer | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | England | British | 172516960001 | |||||
| STILLWELL, Richard Nathan | Geschäftsführer | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | England | British | 80064790001 | |||||
| WILSON, Christopher John | Geschäftsführer | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | England | British | 219228600001 | |||||
| ARMSTRONG, Philippa | Sekretär | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | 201723040001 | |||||||
| ARMSTRONG, Philippa | Sekretär | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | British | 108400480001 | ||||||
| BROOKE, Rosalind | Sekretär | 4 Southview Timsbury BA2 0LZ Bath | British | 16839520002 | ||||||
| CLARKE, David | Sekretär | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | 188800610001 | |||||||
| CLARKE, David | Sekretär | Lower Bristol Road BA2 1EP Bath The Maltings River Place | British | 151390140001 | ||||||
| DA CUNHA, Victor | Sekretär | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | 194531300001 | |||||||
| DA CUNHA, Victor | Sekretär | Lower Bristol Road BA2 1EP Bath The Maltings River Place Uk | British | 159387250001 | ||||||
| HALL, Diane Patricia | Sekretär | 33 Orchard Way North Bradley BA14 0SU Trowbridge Wiltshire | English | 38198930003 | ||||||
| HALL, Diane Patricia | Sekretär | 33 Orchard Way North Bradley BA14 0SU Trowbridge Wiltshire | English | 38198930003 | ||||||
| HASTINGS, Richard | Sekretär | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | 188797000001 | |||||||
| HILL, Alexandra Abigail | Sekretär | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | 194531090001 | |||||||
| INFANTE, Brenda | Sekretär | River Place Lower Bristol Road BA2 1EP Bath The Maltings Uk | British | 177383710001 | ||||||
| MOXHAM, Maria | Sekretär | 2 Pinetum Close SN10 5EW Devizes Wiltshire | British | 100167950001 | ||||||
| SMITHERS, Tonia Lorraine | Sekretär | Fosseway Midsomer Norton BA3 4AU Radstock 1 Little Orchard Somerset | British | 128054140001 | ||||||
| WATSON, Steve | Sekretär | Masters Farm Well Road BA3 4SD Emborough Somerset | British | 124975860001 | ||||||
| WILSON, Emily | Sekretär | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | 240507780001 | |||||||
| APPLEYARD, Robin Alan, Cllr | Geschäftsführer | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | United Kingdom | British | 157193430001 | |||||
| BADER, David John | Geschäftsführer | Groves Road NP20 3SP Newport 20 Gwent | United Kingdom | British | 84821210001 | |||||
| BATTERSBY, Tom | Geschäftsführer | Grosvenor Villas BA1 6QL Bath 10 Avon | United Kingdom | British | 133460880002 | |||||
| BLIGH, Juliet Elizabeth | Geschäftsführer | 14 Clyde Road Redland BS6 6RP Bristol Avon | England | British | 108807800001 | |||||
| BLIGH, Juliet Elizabeth | Geschäftsführer | 14 Clyde Road Redland BS6 6RP Bristol Avon | England | British | 108807800001 | |||||
| BRISCOE, Graham Owen | Geschäftsführer | Lower Bristol Road BA2 1EP Bath The Maltings River Place | England | British | 17350840001 | |||||
| CONNOR, Margaret Jacqueline | Geschäftsführer | Ashcroft Avenue Keynsham BS31 2EX Bristol 21 Avon | Uk | British | 80039210002 | |||||
| COURTIER, Dermot Gerard | Geschäftsführer | The Maltings River Place BA2 1EP Lower Bristol Road Bath | United Kingdom | British | 134345640001 | |||||
| DAVEY, Joanna Mary | Geschäftsführer | 2 Glenview Titlands Lane Wookey Hole BA5 1BD Wells Somerset | British | 59582530001 | ||||||
| DAVEY, Joanna Mary | Geschäftsführer | 2 Glenview Titlands Lane Wookey Hole BA5 1BD Wells Somerset | British | 59582530001 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für CURO GROUP (ALBION) LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 10. Okt. 2016 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat CURO GROUP (ALBION) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Shg debenture | Erstellt am 12. Juli 2004 Geliefert am 21. Juli 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee, any nominee, delegate or agent thereof or any receiver, under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed charge all rights under or in respect of the documents, all rights, title and interest in and to the documents, by way of first floating charge the undertaking and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0