TRIBECKA LAND LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTRIBECKA LAND LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04303984
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TRIBECKA LAND LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich TRIBECKA LAND LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    SMITH & WILLIAMSON LLP
    Marmion House 3 Copenhagen Street
    WR1 2HB Worcester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TRIBECKA LAND LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    QUERCUS LAND LIMITED20. Dez. 200520. Dez. 2005
    TRIBECKA LAND LIMITED27. Dez. 200127. Dez. 2001
    FENSHELF 190 LTD12. Okt. 200112. Okt. 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRIBECKA LAND LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für TRIBECKA LAND LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    1 Seiten4.43

    Geänderte Geschäftsanschrift vom No 1 st Swithin Street Worcester Worcestershire WR1 2PY am 16. Mai 2012

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 14. März 2012

    2 Seiten3.6

    legacy

    2 SeitenLQ02

    legacy

    2 SeitenLQ02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 23. Sept. 2011

    3 Seiten3.6

    legacy

    3 SeitenLQ01

    legacy

    3 SeitenLQ01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Twyning Park Twyning Tewkesbury Gloucestershire GL20 6DQ am 31. März 2010

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    1 SeitenCOCOMP

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Nov. 2009

    Kapitalaufstellung am 04. Nov. 2009

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für James Anthony Edward Omalley am 10. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2008

    14 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2007

    6 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2006

    16 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten288b

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    22 SeitenMA

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed quercus land LIMITED\certificate issued on 19/07/06
    2 SeitenCERTNM

    Wer sind die Geschäftsführer von TRIBECKA LAND LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ALLEN, Jayne
    162 Stourbridge Road
    DY1 2ER Dudley
    West Midlands
    Sekretär
    162 Stourbridge Road
    DY1 2ER Dudley
    West Midlands
    British98582630001
    OMALLEY, James Anthony Edward
    Twyning Park
    Twyning
    Worcester
    Geschäftsführer
    Twyning Park
    Twyning
    Worcester
    United KingdomBritish4717550002
    TURVEY, Paula Claire
    1 Saint Marys Close
    Felmersham
    MK43 7JP Bedford
    Bedfordshire
    Sekretär
    1 Saint Marys Close
    Felmersham
    MK43 7JP Bedford
    Bedfordshire
    British63978970001
    MK COMPANY SECRETARIES LIMITED
    198 Silbury Boulevard
    Central Milton Keynes
    MK9 1LL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    198 Silbury Boulevard
    Central Milton Keynes
    MK9 1LL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    900002770001
    TURVEY, Neil William
    1 Saint Marys Close
    Felmersham
    MK43 7JP Bedford
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    1 Saint Marys Close
    Felmersham
    MK43 7JP Bedford
    Bedfordshire
    United KingdomBritish51899270003
    MK COMPANY DIRECTORS LIMITED
    198 Silbury Boulevard
    Central Milton Keynes
    MK9 1LL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    198 Silbury Boulevard
    Central Milton Keynes
    MK9 1LL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    900002760001

    Hat TRIBECKA LAND LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Nov. 2006
    Geliefert am 18. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Ground floor timber street chippenham t/n WT236665. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 315. Apr. 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 303. Apr. 2012Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 3
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. Mai 2006
    Geliefert am 27. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land at haven exchange, walton avenue, felixtowe t/no SK268309. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 27. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 215. Apr. 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 203. Apr. 2012Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 2
    Legal mortgage
    Erstellt am 05. Aug. 2005
    Geliefert am 26. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h land k/a land at haven exchange walton avenue felixstowe. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 26. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Second legal mortgage
    Erstellt am 05. Aug. 2005
    Geliefert am 25. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £400,000 due or to become due from the company to
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land at haven exchange felixstowe suffolk.
    Berechtigte Personen
    • Michael Andrew Parker and Marian Ruth Parker and Christopher Mark Atkin (As Trustees of the Surfglint Limited Executive Pension Scheme)
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Dez. 2004
    Geliefert am 06. Jan. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H ground floor of goldiggers nightclub chippenham. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 06. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 24. Okt. 2004
    Geliefert am 09. Nov. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property being plot 5A stanton europark parkston quay harwich essex. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Mai 2004
    Geliefert am 22. Mai 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plot 4 stanton europark harwich t/nos EX591363 and EX723291. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 22. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 31/01/04 and
    Erstellt am 30. Jan. 2004
    Geliefert am 06. Feb. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Subjects at 177/179 high street, irvine.
    Berechtigte Personen
    • Malcolm Brand
    Transaktionen
    • 06. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 12. Dez. 2003
    Geliefert am 18. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Okt. 2003
    Geliefert am 25. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £58,750 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Land and buildings at 22/22A town hill wrexham and numbers 2 to 4 abbot street wrexham t/n WA699740 and WA593572.
    Berechtigte Personen
    • Staystrip Group Limited
    Transaktionen
    • 25. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Okt. 2003
    Geliefert am 24. Okt. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 2-4 abbot street and 22/22A town hill wrexham. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 24. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over deposits
    Erstellt am 03. Okt. 2003
    Geliefert am 07. Okt. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed charge over any sums deposited or to be deposited by the company in any deposit account of the company held with the bank at any of its branches.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 09/09/03 and dated 17/08/03 and
    Erstellt am 22. Aug. 2003
    Geliefert am 13. Sept. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects known as and forming 177 and 179 high street, irvine.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 13. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. Okt. 2002
    Geliefert am 01. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat TRIBECKA LAND LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    04. März 2013Aufgelöst am
    28. Sept. 2009Antragsdatum
    30. Nov. 2012Abschluss der Liquidation
    18. Nov. 2009Beginn der Liquidation
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Neil Francis Hickling
    Smith & Williamson
    1 St Swithin Street
    WR1 2PY Worcester
    Praktiker
    Smith & Williamson
    1 St Swithin Street
    WR1 2PY Worcester
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praktiker
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Rosalind Jane Goode
    Gva Grimley Limited 10 Stratton Street
    W1J 8JR London
    Receiver Manager
    Gva Grimley Limited 10 Stratton Street
    W1J 8JR London
    Roland Simon Morgan
    Gva Grimley Limited
    10 Stratton Street
    WIJ 8JR London
    Receiver Manager
    Gva Grimley Limited
    10 Stratton Street
    WIJ 8JR London
    3Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Rosalind Jane Goode
    Gva Grimley Limited 10 Stratton Street
    W1J 8JR London
    Receiver Manager
    Gva Grimley Limited 10 Stratton Street
    W1J 8JR London
    Roland Simon Morgan
    Gva Grimley Limited
    10 Stratton Street
    WIJ 8JR London
    Receiver Manager
    Gva Grimley Limited
    10 Stratton Street
    WIJ 8JR London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0