PC-POS (EUROPE) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PC-POS (EUROPE) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04304997 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PC-POS (EUROPE) LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich PC-POS (EUROPE) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 1 Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PC-POS (EUROPE) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PC-POS EUROPE LIMITED | 30. Nov. 2001 | 30. Nov. 2001 |
| AVONMARSH LIMITED | 16. Okt. 2001 | 16. Okt. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PC-POS (EUROPE) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PC-POS (EUROPE) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Meirion Warwick-Saunders als Sekretär am 05. Aug. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Victoria Anne Chandler als Sekretär am 17. Aug. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Sept. 2015 bis 29. Sept. 2015 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Stanley Wright als Geschäftsführer am 27. Nov. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mel David Taylor als Direktor am 27. Nov. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Alan Stanley Wright als Direktor am 17. Juni 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thierry Georges Bouzac als Geschäftsführer am 01. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Oliver Carl Archer als Direktor am 26. Nov. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Keith Christopher Gibbon als Geschäftsführer am 14. Nov. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Thierry Georges Bouzac als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PC-POS (EUROPE) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANDLER, Victoria Anne | Sekretär | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire | 212444490001 | |||||||
| ARCHER, Oliver Carl | Geschäftsführer | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire | England | British | 150218430001 | |||||
| TAYLOR, Mel David | Geschäftsführer | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire | England | English | 203242420001 | |||||
| BARRELL, Henry James | Sekretär | 76 Portsmouth Road PO13 9AF Lee On The Solent Hampshire | British | 10139240001 | ||||||
| CHURCH, Lisa | Sekretär | Houndmills Industrial Estate Hamilton Road RG21 6YT Basingstoke Unit 4 Hampshire | 146562410001 | |||||||
| HARRISON, Irene Lesley | Bevollmächtigter Sekretär | Fy Mwthin 22 Merthyr Road Tongwynlais CF15 7LH Cardiff South Glamorgan | British | 900003790001 | ||||||
| WARWICK-SAUNDERS, Richard Meirion | Sekretär | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | 163278470001 | |||||||
| WILLIAMS, Huw Llewelyn Francis | Sekretär | Archways Alexandria Road Sutton Scotney SO21 3LF Winchester Hampshire | British | 73616300001 | ||||||
| AHLANDER, Gunnar | Geschäftsführer | Oskarsgatan 2d 149 34 Nynashaun Sweden | Swedish | 82476030001 | ||||||
| ASPLIN, Robert Alexander | Geschäftsführer | Houndmills Industrial Estate Hamilton Road RG21 6YT Basingstoke Unit 4 Hampshire | Uk | British | 149870270001 | |||||
| BARRELL, Henry James | Geschäftsführer | 76 Portsmouth Road PO13 9AF Lee On The Solent Hampshire | United Kingdom | British | 10139240001 | |||||
| BELL, Donald Mcrae | Geschäftsführer | Cos Siomaich 2 Charlcot Winchester Road RG28 7RG Whitchurch Hampshire | British | 50359290001 | ||||||
| BITTLESTON, Timothy Steven | Geschäftsführer | The Chimneys 73 Station Road DE13 8DS Barton Under Needwood Staffordshire | British | 74438980001 | ||||||
| BOUZAC, Thierry Georges | Geschäftsführer | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire | England | French | 87674390003 | |||||
| GIBBON, David Keith Christopher | Geschäftsführer | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | England | British | 49959390002 | |||||
| GUTTERIDGE, Grant Michael | Geschäftsführer | Hope House 45 Bluehouse Lane RH8 0AJ Oxted Surrey | British | 88032870001 | ||||||
| HILDALGO, Tony | Geschäftsführer | Lyndhurst Dr L6H7V7 Oakville 2390 Ontario | Canada | Canadian | 147303510001 | |||||
| MALMSTROM, Hans Book | Geschäftsführer | Bournonvillesvej 2a Fredensborg Dk-3480 Denmark | Danish | 87614950001 | ||||||
| MCGREGOR, Garth Bruce | Geschäftsführer | 30 Pineslope Park Estate FOREIGN Lone Hill South Africa South Africa | South African | 84797810001 | ||||||
| PATTERSON, Ian James | Geschäftsführer | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 102523780001 | |||||
| TEE, Fiona | Geschäftsführer | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 66385440005 | |||||
| TIMOTHY, Fiona Maria | Geschäftsführer | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | England | British | 161343370001 | |||||
| WILLIAMS, Huw Llewelyn Francis | Geschäftsführer | Archways Alexandria Road Sutton Scotney SO21 3LF Winchester Hampshire | England | British | 73616300001 | |||||
| WORSFOLD, Graham Robert | Geschäftsführer | 27 Spring Grove KT22 9NN Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | 91654570001 | |||||
| WRIGHT, Alan Stanley | Geschäftsführer | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire | England | British | 83067060001 | |||||
| WUSCHANSKY, Bernd Georg | Geschäftsführer | Geyersperger Strasse 26 FOREIGN Munich D-80689 Germany | Germany | German | 99458490001 | |||||
| WUSCHANSKY, Bernd Georg | Geschäftsführer | Geyersperger Strasse 26 FOREIGN Munich D-80689 Germany | Germany | German | 99458490001 | |||||
| BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Crown House 64 Whitchurch Road CF14 3LX Cardiff | 900005500001 |
Hat PC-POS (EUROPE) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 02. Juli 2012 Geliefert am 11. Juli 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the real property, all licenses, proceeds of sale, plant and machinery, all computers, vehicles, office equipment, the benefit of all contracts, charged securities, intelelctual property, goodwill and uncalled capital, the relevant contracts, insurances and all other receivables see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares | Erstellt am 31. Aug. 2004 Geliefert am 18. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Pc-pos limited 1,000 ordinary shares; pc-pos (UK) limited 90,730 a ordinary shares and 9,270 b ordinary shares; odessa management limited 95,000 ordinary shares and 1,802 a ordinary shares. For details of further shares charged please refer to form 395. and all other stock, shares, bonds, all dividends, interest or other distributions. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares | Erstellt am 08. Dez. 2003 Geliefert am 22. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The securities being pc-pos (UK) limited 100,000 a ordinary shares, real time control international limited 1 ordinary share, odessa management limited 95,000 ordinary shares and 1,802 a ordinary shares (for further details of securities charged please see schedule to form 395) all dividends interest or other distributions, all allotments accretions offers, all stocks shares rights money or property accruing, all cash debentures or other obligations. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge of financial instruments account | Erstellt am 22. Aug. 2003 Geliefert am 10. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Pledged the financial instruments account, all of the pledgor's rights title benefit anf interest in all securities which may be substituted for or received in respect of the financial instruments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Aug. 2003 Geliefert am 30. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share pledge | Erstellt am 22. Aug. 2003 Geliefert am 04. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The existing shares and all additonal shares in the capital of the german company in whatever nominal value which the company may acquire in the future in the event of a share transfer, an increase of the capital of the german company or otherwise. The present and future rights to receive dividends payable in relation to the shares. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 22. Aug. 2003 Geliefert am 30. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All stocks, shares, bonds, debentures, loan stock, all dividends, interest or other distributions. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Jan. 2002 Geliefert am 17. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0