CHESTERFIELD MSA FORECOURTS LIMITED

CHESTERFIELD MSA FORECOURTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCHESTERFIELD MSA FORECOURTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04306997
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CHESTERFIELD MSA FORECOURTS LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich CHESTERFIELD MSA FORECOURTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Peterborough Services Great North Road
    Haddon
    PE7 3UQ Peterborough
    Cambridgeshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CHESTERFIELD MSA FORECOURTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HAMSARD 2403 LIMITED18. Okt. 200118. Okt. 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHESTERFIELD MSA FORECOURTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis06. Okt. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für CHESTERFIELD MSA FORECOURTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    legacy

    9 SeitenMG04

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Craig Stuart Beevers als Geschäftsführer am 13. Mai 2011

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Okt. 2011

    Kapitalaufstellung am 05. Okt. 2011

    • Kapital: GBP 7,327,001
    SH01

    Ernennung von Mr Trishul Thakore als Direktor

    3 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 06. Okt. 2010

    18 SeitenAA

    Verschiedenes

    Section 519
    2 SeitenMISC

    Verschiedenes

    Section 519
    2 SeitenMISC

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Apr. 2010 bis 06. Okt. 2010

    1 SeitenAA01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Castle Hill Lincoln Lincolnshire LN1 3AA am 05. Nov. 2010

    2 SeitenAD01

    Ernennung von Harold Denis Mccarney als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Craig Stuart Beevers als Direktor

    3 SeitenAP01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Beendigung der Bestellung von Robert Wade als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Timothy Spouge als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Spouge als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Gordon Pullan als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Geoffrey Goodwill als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Gordon Pullan als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01

    legacy

    38 SeitenMG01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2009

    20 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von CHESTERFIELD MSA FORECOURTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MCCARNEY, Harold Denis
    180 Piccadilly
    W1J 93R London
    6th Floor
    England
    Sekretär
    180 Piccadilly
    W1J 93R London
    6th Floor
    England
    British155464290001
    THAKORE, Trishul
    Piccadily
    W1J 9ER London
    6th Floor 180
    Geschäftsführer
    Piccadily
    W1J 9ER London
    6th Floor 180
    United KingdomBritishDirector159206370001
    PULLAN, Gordon Waite
    The Water Tower
    Potterhanworth
    LN4 2DN Lincoln
    Sekretär
    The Water Tower
    Potterhanworth
    LN4 2DN Lincoln
    BritishChartered Accountant72016900002
    HAMMONDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Sekretär
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580008
    BEEVERS, Craig Stuart
    180 Piccadilly
    W1J 9ER London
    6th Floor
    England
    Geschäftsführer
    180 Piccadilly
    W1J 9ER London
    6th Floor
    England
    EnglandBritishDirector103311310001
    GOODWILL, Geoffrey Mortimer
    White Court
    5 Foxhill Drive, Weetwood
    LS16 5PG Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    White Court
    5 Foxhill Drive, Weetwood
    LS16 5PG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor100020003
    LONG, Andrew Edward
    The Old Rectory
    Rectory Road, Coleby
    LN5 0AJ Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Rectory Road, Coleby
    LN5 0AJ Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor2537680002
    PULLAN, Gordon Waite
    The Water Tower
    Potterhanworth
    LN4 2DN Lincoln
    Geschäftsführer
    The Water Tower
    Potterhanworth
    LN4 2DN Lincoln
    EnglandBritishChartered Accountant72016900002
    SPOUGE, Stephen William
    1 Castle Hill
    Lincoln
    LN1 3AA Lincolnshire
    Geschäftsführer
    1 Castle Hill
    Lincoln
    LN1 3AA Lincolnshire
    EnglandBritishDirector2537020001
    SPOUGE, Stephen William
    The Grange Barlings
    Langworth
    LN3 5DG Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    The Grange Barlings
    Langworth
    LN3 5DG Lincoln
    Lincolnshire
    EnglandBritishProperty Developer2537020001
    SPOUGE, Timothy James
    The Grange
    Barlings, Langworth
    LN3 5DG Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    The Grange
    Barlings, Langworth
    LN3 5DG Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritishMotor Racing Driver Farm Manag46349280001
    SPOUGE, Timothy James
    The Grange
    Barlings, Langworth
    LN3 5DG Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    The Grange
    Barlings, Langworth
    LN3 5DG Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritishMotor Racing Driver Farm Manag46349280001
    WADE, Robert Alexander Mercer
    Vergers House
    1 The Old Palace Palace Road
    HG4 3HF Ripon
    Geschäftsführer
    Vergers House
    1 The Old Palace Palace Road
    HG4 3HF Ripon
    United KingdomBritishConsultant14261170002
    HAMMONDS DIRECTORS LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Geschäftsführer
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    73774730003

    Hat CHESTERFIELD MSA FORECOURTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 06. Okt. 2010
    Geliefert am 16. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transaktionen
    • 16. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 13. Apr. 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Debenture
    Erstellt am 24. Juni 2008
    Geliefert am 01. Juli 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 01. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 24. Okt. 2007
    Geliefert am 27. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties or any of them on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land k/a fuel forecourts and fuel shop at tibshelf motorway service area, M1, chesterfield t/no DY300552 and DY341678. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 27. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2005
    Geliefert am 28. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor to any of the finance parties (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 28. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 22. Nov. 2004
    Geliefert am 07. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company with full title guarantee charges to the creditor as security for the payment or discharge of the secured obligations by way of floating charge all the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Texaco Limited
    Transaktionen
    • 07. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage and legal charge
    Erstellt am 22. Nov. 2004
    Geliefert am 07. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a interest in the land and buildings to the east and west side of the M1 motorway, tibshelf, derbyshi. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Texaco Limited
    Transaktionen
    • 07. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession to a composite debenture dated 11 june 2004
    Erstellt am 22. Nov. 2004
    Geliefert am 26. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any of the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H land k/a fuel forecourts and fuel shop at tibshelf motorway service area M1 chesterfield t/nos DY300552 and DY341678. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0