CHESTERFIELD MSA FORECOURTS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CHESTERFIELD MSA FORECOURTS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04306997 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHESTERFIELD MSA FORECOURTS LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich CHESTERFIELD MSA FORECOURTS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Peterborough Services Great North Road Haddon PE7 3UQ Peterborough Cambridgeshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CHESTERFIELD MSA FORECOURTS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
HAMSARD 2403 LIMITED | 18. Okt. 2001 | 18. Okt. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHESTERFIELD MSA FORECOURTS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 06. Okt. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHESTERFIELD MSA FORECOURTS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
legacy | 9 Seiten | MG04 | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Craig Stuart Beevers als Geschäftsführer am 13. Mai 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Trishul Thakore als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 06. Okt. 2010 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Apr. 2010 bis 06. Okt. 2010 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Castle Hill Lincoln Lincolnshire LN1 3AA am 05. Nov. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Harold Denis Mccarney als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr Craig Stuart Beevers als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Wade als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Spouge als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Spouge als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gordon Pullan als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Geoffrey Goodwill als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gordon Pullan als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 38 Seiten | MG01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2009 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CHESTERFIELD MSA FORECOURTS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCCARNEY, Harold Denis | Sekretär | 180 Piccadilly W1J 93R London 6th Floor England | British | 155464290001 | ||||||
THAKORE, Trishul | Geschäftsführer | Piccadily W1J 9ER London 6th Floor 180 | United Kingdom | British | Director | 159206370001 | ||||
PULLAN, Gordon Waite | Sekretär | The Water Tower Potterhanworth LN4 2DN Lincoln | British | Chartered Accountant | 72016900002 | |||||
HAMMONDS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 67382580008 | |||||||
BEEVERS, Craig Stuart | Geschäftsführer | 180 Piccadilly W1J 9ER London 6th Floor England | England | British | Director | 103311310001 | ||||
GOODWILL, Geoffrey Mortimer | Geschäftsführer | White Court 5 Foxhill Drive, Weetwood LS16 5PG Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 100020003 | ||||
LONG, Andrew Edward | Geschäftsführer | The Old Rectory Rectory Road, Coleby LN5 0AJ Lincoln Lincolnshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 2537680002 | ||||
PULLAN, Gordon Waite | Geschäftsführer | The Water Tower Potterhanworth LN4 2DN Lincoln | England | British | Chartered Accountant | 72016900002 | ||||
SPOUGE, Stephen William | Geschäftsführer | 1 Castle Hill Lincoln LN1 3AA Lincolnshire | England | British | Director | 2537020001 | ||||
SPOUGE, Stephen William | Geschäftsführer | The Grange Barlings Langworth LN3 5DG Lincoln Lincolnshire | England | British | Property Developer | 2537020001 | ||||
SPOUGE, Timothy James | Geschäftsführer | The Grange Barlings, Langworth LN3 5DG Lincoln Lincolnshire | United Kingdom | British | Motor Racing Driver Farm Manag | 46349280001 | ||||
SPOUGE, Timothy James | Geschäftsführer | The Grange Barlings, Langworth LN3 5DG Lincoln Lincolnshire | United Kingdom | British | Motor Racing Driver Farm Manag | 46349280001 | ||||
WADE, Robert Alexander Mercer | Geschäftsführer | Vergers House 1 The Old Palace Palace Road HG4 3HF Ripon | United Kingdom | British | Consultant | 14261170002 | ||||
HAMMONDS DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 73774730003 |
Hat CHESTERFIELD MSA FORECOURTS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 06. Okt. 2010 Geliefert am 16. Okt. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 24. Juni 2008 Geliefert am 01. Juli 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 24. Okt. 2007 Geliefert am 27. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the finance parties or any of them on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land k/a fuel forecourts and fuel shop at tibshelf motorway service area, M1, chesterfield t/no DY300552 and DY341678. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite debenture | Erstellt am 21. Dez. 2005 Geliefert am 28. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to any of the finance parties (or any of them) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 22. Nov. 2004 Geliefert am 07. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company with full title guarantee charges to the creditor as security for the payment or discharge of the secured obligations by way of floating charge all the assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage and legal charge | Erstellt am 22. Nov. 2004 Geliefert am 07. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h property k/a interest in the land and buildings to the east and west side of the M1 motorway, tibshelf, derbyshi. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of accession to a composite debenture dated 11 june 2004 | Erstellt am 22. Nov. 2004 Geliefert am 26. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any of the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H land k/a fuel forecourts and fuel shop at tibshelf motorway service area M1 chesterfield t/nos DY300552 and DY341678. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0