ALBEMARLE ONE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameALBEMARLE ONE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04310482
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ALBEMARLE ONE LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich ALBEMARLE ONE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ALBEMARLE ONE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FORSTERS SHELFCO 116 LIMITED24. Okt. 200124. Okt. 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ALBEMARLE ONE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für ALBEMARLE ONE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    17 SeitenWU15

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD zum 30 Old Bailey London EC4M 7AU am 11. Mai 2022

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    13 SeitenWU07

    Fortschrittsbericht bei einer Liquidation durch das Gericht

    16 SeitenWU07

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Egan Property Asset Management 66 Grosvenor Street London W1K 3JL zum Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD am 07. Feb. 2020

    1 SeitenAD01

    Ernennung eines Liquidators

    3 SeitenWU04

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    3 SeitenCOCOMP

    legacy

    2 SeitenAC93

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2016

    5 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Juni 2016 bis 29. Juni 2016

    1 SeitenAA01

    Bestätigungserklärung erstellt am 26. Sept. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2015 bis 30. Juni 2016

    1 SeitenAA01

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    2 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Sept. 2015

    Kapitalaufstellung am 29. Sept. 2015

    • Kapital: GBP 505,000
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    7 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von ALBEMARLE ONE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAVY, John Robert
    Shirlock Road
    NW3 2HS London
    24
    Geschäftsführer
    Shirlock Road
    NW3 2HS London
    24
    United KingdomBritish141284220001
    EGAN, Geoffrey Robert
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    Geschäftsführer
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    United KingdomBritish4045260002
    DAVY, John Robert
    1 Rupert Road
    W4 1LU London
    Sekretär
    1 Rupert Road
    W4 1LU London
    British70068680003
    MCVITTY, Christopher William
    Lyndhurst
    20 Colburn Avenue
    CR3 6HU Caterham
    Surrey
    Sekretär
    Lyndhurst
    20 Colburn Avenue
    CR3 6HU Caterham
    Surrey
    British37936110003
    PARSONS, Mark
    c/o Egan Property Asset Management
    Grosvenor Street
    W1K 3JL London
    66
    United Kingdom
    Sekretär
    c/o Egan Property Asset Management
    Grosvenor Street
    W1K 3JL London
    66
    United Kingdom
    156201190001
    FORSTERS SECRETARIES LIMITED
    67 Grosvenor Street
    W1K 3JN London
    Sekretär
    67 Grosvenor Street
    W1K 3JN London
    60863750002
    ASKEW, Neville John
    Holwood
    Shire Lane
    WD3 5NR Chorleywood
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Holwood
    Shire Lane
    WD3 5NR Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish79435440001
    EGAN, Geoffrey Robert
    Burges Grove
    Barnes
    SW13 8BG London
    4
    Geschäftsführer
    Burges Grove
    Barnes
    SW13 8BG London
    4
    United KingdomBritish4045260002
    EGAN, Geoffrey Robert
    4 Burges Grove
    Barnes
    SW13 8BG London
    Geschäftsführer
    4 Burges Grove
    Barnes
    SW13 8BG London
    United KingdomBritish4045260002
    FREDERIKSE, Thomas Anthony
    24 Countess Road
    Kentish Town
    NW5 2XJ London
    Geschäftsführer
    24 Countess Road
    Kentish Town
    NW5 2XJ London
    EnglandUs78422810001
    PARSONS, Park
    c/o Egan Property Asset Management
    Grosvenor Street
    W1K 3JL London
    66
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o Egan Property Asset Management
    Grosvenor Street
    W1K 3JL London
    66
    United Kingdom
    United KingdomBritish156201420001
    RYAN, Claire
    242a Fulham Road
    SW10 9NA London
    Geschäftsführer
    242a Fulham Road
    SW10 9NA London
    Irish82118490001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ALBEMARLE ONE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr John Robert Davy
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    06. Apr. 2016
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 50%, aber nicht mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 50%, aber nicht mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat ALBEMARLE ONE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fee agreement second charge
    Erstellt am 09. März 2011
    Geliefert am 10. März 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    69,71 and 73 stafford street hanley stoke on trent t/no SF269605,land on the west side of brockley square hanley stoke on trent t/no SF457967,car park at weaver street hanley stoke on trent t/no SF254326 (for further details of propertyn charged please refer to form MG01) by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • West Register (Trading) Limited
    Transaktionen
    • 10. März 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Sept. 2005
    Geliefert am 01. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Carpark at weaver street hanley stoke on trent t/n SF254326. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Sept. 2005
    Geliefert am 01. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land on the west side brockley square hanley stoke on trent t/n SF457967. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Sept. 2005
    Geliefert am 01. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    69, 71 and 73 stafford street hanley stoke on trebt t/n sf 269605. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Sept. 2005
    Geliefert am 01. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    10 trinity street hanley stoke on trent t/n SF360599. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 16. Sept. 2005
    Geliefert am 01. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Sept. 2005
    Geliefert am 01. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land lying to the east of foundry street hanley stoke on trent t/n SF236817. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal assignment of rent
    Erstellt am 16. Sept. 2005
    Geliefert am 01. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right title interest and benefit in to the rent. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 19. Juni 2002
    Geliefert am 10. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as 1 to 9 (odd nos) brockley square hanley,69 to 71 stafford st,hanley,1-4 grosvenor chambers hanley and land at weaver st,hanley; t/nos SF236817,SF269605,SF240257,SF360599 and SF254326; all fixtures,fittings,goodwill of any trade or business and all interest,monies,deposits paid thereon;the rights under any contracts and any copyrights or licence,all guarantees and warranties,etc; all plant machinery fixtures and fittings thereon and all rental deposits; floating charge over. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Britannia Building Society
    Transaktionen
    • 10. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat ALBEMARLE ONE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    13. Jan. 2023Abschluss der Liquidation
    10. Sept. 2019Antragsdatum
    23. Okt. 2019Beginn der Liquidation
    25. Juni 2023Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praktiker
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Adam Harris
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Praktiker
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Michael Pallott
    Tower Bridge House
    St Katherine'S Way
    E1W 1DD London
    Praktiker
    Tower Bridge House
    St Katherine'S Way
    E1W 1DD London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0