FREEPORT (NOMINEE 1) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FREEPORT (NOMINEE 1) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04310590 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FREEPORT (NOMINEE 1) LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich FREEPORT (NOMINEE 1) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 100 Victoria Street SW1E 5JL London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FREEPORT (NOMINEE 1) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| IBIS (718) LIMITED | 24. Okt. 2001 | 24. Okt. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FREEPORT (NOMINEE 1) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FREEPORT (NOMINEE 1) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Okt. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Okt. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Ls Braintree and Castleford Gp Limited as a person with significant control on 18. Mai 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Louise Miller als Geschäftsführer am 01. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Elizabeth Miles als Direktor am 01. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2017 bis 31. März 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Change of details for Hermes Freeport Gp Limited as a person with significant control on 26. Mai 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Change of details for Hermes Freeport Gp Limited as a person with significant control on 18. Mai 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | RP04CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hermes Secretariat Limited als Sekretär am 15. Mai 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kirsty Ann-Marie Wilman als Geschäftsführer am 15. Mai 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Leonard Grose als Geschäftsführer am 15. Mai 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew James Torode als Geschäftsführer am 15. Mai 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ls Director Limited als Direktor am 15. Mai 2017 | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Ernennung von Ls Company Secretaries Limited als Sekretär am 15. Mai 2017 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Ernennung von Land Securities Management Services Limited als Direktor am 15. Mai 2017 | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Ernennung von Louise Miller als Direktor am 15. Mai 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FREEPORT (NOMINEE 1) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS COMPANY SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 159674790001 | ||||||||||
| MILES, Elizabeth | Geschäftsführer | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | 235498150001 | |||||||||
| LAND SECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 74974580001 | ||||||||||
| LS DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 133814600001 | ||||||||||
| BROWNSTEIN, Ian Jeffrey | Sekretär | Conifers 59 Deacons Hill Road Elstree WD6 3HZ Borehamwood Hertfordshire | British | 44779830001 | ||||||||||
| DECHERT SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 2 Serjeants Inn EC4Y 1LT London | 900021440001 | |||||||||||
| HERMES SECRETARIAT LIMITED | Sekretär | 1 Portsoken Street E1 8HZ London Lloyds Chambers United Kingdom |
| 93700910001 | ||||||||||
| ADAMS, Elizabeth Ann | Geschäftsführer | 10 Sunlight Square Bethnal Green E2 6LD London | British | 83483930001 | ||||||||||
| ALLEN, Stephen | Geschäftsführer | Walden Way RM11 2LB Hornchurch 9 Essex United Kingdom | England | British | 109415360002 | |||||||||
| BROWNSTEIN, Ian Jeffrey | Geschäftsführer | Conifers 59 Deacons Hill Road Elstree WD6 3HZ Borehamwood Hertfordshire | British | 44779830001 | ||||||||||
| BURROWES, David William | Geschäftsführer | 60 Westwater Way OX11 7TY Didcot Oxfordshire | United Kingdom | British | 100504300001 | |||||||||
| COLLIDGE, Sean Mervyn | Geschäftsführer | Apartment 4a4 Block B L' Hersilia 33 Rue Du Portier 98000 Monaco | British | 38994860002 | ||||||||||
| DEWHIRST, Andrew David | Geschäftsführer | 59 Old Park View EN2 7EQ Enfield Middlesex | United Kingdom | British | 29539910003 | |||||||||
| FRANKLIN, Jennifer Ann | Geschäftsführer | 1 Portsoken Street E1 8HZ London Lloyds Chambers | England | British | 154430800001 | |||||||||
| GROSE, David Leonard | Geschäftsführer | Victoria Street SW1E 5JL London 100 England | United Kingdom | British | 120479020004 | |||||||||
| MILLER, Louise | Geschäftsführer | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | 199935770001 | |||||||||
| MOUSLEY, Emily Ann | Geschäftsführer | 1 Portsoken Street E1 8HZ London Lloyds Chambers | England | British | 155262770003 | |||||||||
| MOUSLEY, Emily Ann | Geschäftsführer | Flat C, 1 Cranley Gardens, Muswell Hill N10 3AA London | United Kingdom | British | 155262770001 | |||||||||
| PIERCE, Graham Charles | Geschäftsführer | 66 Lausanne Road SE15 2JB London | United Kingdom | Uk | 123665160001 | |||||||||
| RUSSELL, Gary Allan Mason | Geschäftsführer | Apartment 1181 4th Floor, Palais De La Scala 1 Avenue Henri Dunnant 98000 Monaco | British | 57226640002 | ||||||||||
| TORODE, Matthew James | Geschäftsführer | Victoria Street SW1E 5JL London 100 England | United Kingdom | British | 196412900002 | |||||||||
| WILMAN, Kirsty Ann-Marie | Geschäftsführer | Victoria Street SW1E 5JL London 100 England | England | British | 155163600003 | |||||||||
| WOOLLEY, Peter Thomas Griffith | Geschäftsführer | Apartment 5a2 Block A Le Montaigne 2 Avenue De La Madone 98000 Monaco | British | 39676720009 | ||||||||||
| DECHERT NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 2 Serjeants Inn EC4Y 1LT London | 900021430001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FREEPORT (NOMINEE 1) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ls Braintree And Castleford Gp Limited | 06. Apr. 2016 | Victoria Street SW1E 5JL London 100 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat FREEPORT (NOMINEE 1) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 20. Dez. 2004 Geliefert am 30. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h land k/a land lying to the north west of charter way braintree t/no's EX632902 and EX603735 the f/h land k/a freeport retails village tomahawk trail castleford t/n WYK708788 and WYK710458 the l/h land k/a freeport village amounderness way fleetwood t/n LA845311 all buildings fixtures fixed plant and machinery its goodwill uncalled capital its book and other debts by way of a first floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document | Erstellt am 23. März 2004 Geliefert am 25. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or freeport (nominee 2) limited to the security trustee as agent or the security trustee and/or possfund custodian trustee limited (together "the lenders") | |
Kurze Angaben Freeport village braintree braintree essex t/ns EX603735 and EX632902 freeport village fleetwood fleetwood lancashire t/n LA845311 freeport village castleford yorkshire t/ns WYK708788 and WYK710458. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge between (1) freeport limited partnership (acting by its general partner), (2) freeport (general partner) limited, (3) freeport (nominee 1) limited, (4) freeport (nominee 2) limited in favour of (5) barclays bank PLC | Erstellt am 05. Juni 2002 Geliefert am 22. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The property k/a freeport village braintree, braintree, essex t/no. EX603735 and EX632902, freeport village hornsea, hornsea, east yorkshire t/no. HS237817, freeport village fleetwood, fleetwood, lancashire t/no. LA845311 (for full details of property charged please see schedule 3 to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 08. März 2002 Geliefert am 26. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Its undertaking and assets both present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Juni 2001 Erworben am 08. März 2002 Geliefert am 27. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Mai 2001 Erworben am 08. März 2002 Geliefert am 27. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The l/h property k/a freeport village, amounderness way, fleetwood, t/no LA845311. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Development debenture | Erstellt am 24. Aug. 1999 Erworben am 08. März 2002 Geliefert am 27. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben By way of fixed charge the property k/a freeport village braintree, braintree, essex, t/no EX603735. The other property and the future property and all rights relating to the property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Juni 1999 Erworben am 08. März 2002 Geliefert am 27. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The l/h property k/a freeport village, amounderness way, fleetwood, t/no LA845311. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Juni 1996 Erworben am 08. März 2002 Geliefert am 27. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The f/h property k/a the land and buildings on the west side of rolston road, hornsea, t/nos HS237817. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0