C I S TOOLING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | C I S TOOLING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04312874 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von C I S TOOLING LIMITED?
- Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche
Wo befindet sich C I S TOOLING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 2, Oxford Building School Lane Colmworth MK44 2JZ Bedford England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von C I S TOOLING LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DRIVEHOME LIMITED | 29. Okt. 2001 | 29. Okt. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von C I S TOOLING LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für C I S TOOLING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Dez. 2019 | 5 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Dez. 2018 | 5 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2018 bis 30. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Alison Breslin am 07. Feb. 2019 | 1 Seiten | CH03 | ||
Änderung der Details des Direktors für Alison Breslin am 07. Feb. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Okt. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 6 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Cessation of Sylvia Alison Breslin as a person with significant control on 08. Apr. 2017 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Cessation of Rachel Bell as a person with significant control on 08. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Cessation of Bryan James Stuart Clover as a person with significant control on 08. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Notification of Sylvia Alison Breslin as a person with significant control on 07. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Notification of Bryan James Stuart Clover as a person with significant control on 07. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Notification of Rachel Bell as a person with significant control on 07. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 10 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Bryan James Stuart Clover am 11. Nov. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Rachel Bell am 11. Nov. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 6 Seiten | AA | ||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von C I S TOOLING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRESLIN, Sylvia Alison | Sekretär | Copper Cottage Church End MK44 2RP Ravensdon Bedfordshire | British | Manager | 106051810005 | |||||
| BELL, Rachel Anne | Geschäftsführer | Dibles Lane West Coker BA22 9AH Yeovil Westlake House Somerset England | United Kingdom | British | Director | 83843200002 | ||||
| BRESLIN, Sylvia Alison | Geschäftsführer | Copper Cottage Church End MK44 2RP Ravensdon Bedfordshire | England | British | Manager | 106051810005 | ||||
| CLOVER, Bryan James Stuart | Geschäftsführer | 107 Caxton End Bourn CB23 2ST Cambridge The Apiary England | England | British | Managing Director | 57504680005 | ||||
| BELL, Sylvia | Sekretär | Carillon Horne Lane SG19 2LS Potton Bedfordshire | British | Administrator | 15875720001 | |||||
| RWL REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Regis House 134 Percival Road EN1 1QU Enfield Middlesex | 900007870001 | |||||||
| BELL, Sylvia | Geschäftsführer | Carillon Horne Lane SG19 2LS Potton Bedfordshire | British | Administrator | 15875720001 | |||||
| BONUSWORTH LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Regis House 134 Percival Road EN1 1QU Enfield Middlesex | 900006860001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei C I S TOOLING LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrs Sylvia Alison Breslin | 07. Apr. 2016 | MK44 2RP Ravensdon Copper Cottage Church End Bedfordshire United Kingdom | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Ms Rachel Bell | 07. Apr. 2016 | Dibles Lane West Coker BA22 9AH Yeovil Westlake House Somerset England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Bryan James Stuart Clover | 07. Apr. 2016 | 107 Caxton End CB23 2ST Bourn The Apiary Cambridgeshire United Kingdom | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Carillon Industrial Services Limited | 06. Apr. 2016 | School Lane Colmworth MK44 2JZ Bedford Unit 2 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat C I S TOOLING LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of legal mortgage | Erstellt am 27. Juli 2012 Geliefert am 03. Aug. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 7, marlborough road. Colmworth business park, eaton socon, st neots, cambridgeshire. All plant and machinery owned by the company and its interest in any plant and machinery. All fixtures and fittings all other chattels and all benefits in respect of the insurances including claims and the refund of any premiums and all rents receivable from any lease granted of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 27. Juli 2012 Geliefert am 01. Aug. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. März 2002 Geliefert am 20. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 2 phase 3A colmworth business park,eaton socon st neots cambridgeshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture by the company and carillon industrial services limited | Erstellt am 29. Nov. 2001 Geliefert am 12. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0