C.G.I.S. TEWKESBURY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameC.G.I.S. TEWKESBURY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04316721
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von C.G.I.S. TEWKESBURY LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich C.G.I.S. TEWKESBURY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    10 Upper Berkeley Street
    London
    W1H 7PE
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von C.G.I.S. TEWKESBURY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    C.G.I.S. SALISBURY LIMITED28. Nov. 200128. Nov. 2001
    DWSCO 2212 LIMITED05. Nov. 200105. Nov. 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von C.G.I.S. TEWKESBURY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für C.G.I.S. TEWKESBURY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 11. Juli 2016

    • Kapital: GBP 1
    5 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2015

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Dez. 2015

    Kapitalaufstellung am 01. Dez. 2015

    • Kapital: GBP 3,023.24
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2014

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Nov. 2014

    Kapitalaufstellung am 18. Nov. 2014

    • Kapital: GBP 3,023.24
    SH01

    Erfüllung der Belastung 043167210008 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2013

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Dez. 2013

    Kapitalaufstellung am 16. Dez. 2013

    • Kapital: GBP 3,023.24
    SH01

    Eintragung der Belastung 043167210008

    32 SeitenMR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2012

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2011

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    legacy

    8 SeitenMG01

    Wer sind die Geschäftsführer von C.G.I.S. TEWKESBURY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    STEINBERG, Mark Neil
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    Sekretär
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    British59275730001
    COLE, Terence Shelby
    Phillimore Gardens
    W8 7QE London
    24
    Geschäftsführer
    Phillimore Gardens
    W8 7QE London
    24
    United KingdomBritish71810060003
    COLLINS, Steven Ross
    Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PL London
    70
    Geschäftsführer
    Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PL London
    70
    United KingdomBritish7128850001
    STEINBERG, Mark Neil
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    Geschäftsführer
    Wadham Gardens
    NW3 3DN London
    11
    United KingdomBritish59275730001
    DWS SECRETARIES LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900023840001
    DWS DIRECTORS LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900023830001

    Hat C.G.I.S. TEWKESBURY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 06. Sept. 2013
    Geliefert am 20. Sept. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    N/A. notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Sculptor Finance (Md) Limited
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 01. Okt. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Floating charge
    Erstellt am 01. Juli 2010
    Geliefert am 12. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the finance parties (or any of them) or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of floating charge all its undertaking and all property assets and rights.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC for Itself and as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 12. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Floating charge
    Erstellt am 05. Juli 2005
    Geliefert am 22. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Floating charge all its undertaking and all its property, assets and rights both present and future.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for and on Behalf of Thelenders
    Transaktionen
    • 22. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fifty-fifth supplemental trust deed
    Erstellt am 05. Juli 2005
    Geliefert am 12. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by hemingway debenture limited to the trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the new property being f/h land k/a plot 5300 being part of land at tewkesbury business park northway lane tewkesbury t/n GR248788. F/h land being la fitness (also k/a north birmingham squash rackets club) 366 gravelly lane erdington birmingham t/n's WM108627 WN682318 WM232394 WM629635 and WM744301. L/h land at mill street brierley hill west midlands t/n WM775455. For further details of property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transaktionen
    • 12. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 04. Mai 2005
    Geliefert am 06. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h land known as part plot 5300, tewkesbury business park northway lane tewkesbury t/n GR248788, fixed and floating charges over the undertaking and all property present and future including goodwill uncalled capital fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 06. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deeds of accession to a subordination deed dated 24 december 2002 pursuant to which the company will become an obligor and subordinated creditor under the subordination deed and
    Erstellt am 20. März 2003
    Geliefert am 02. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by an obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All present and future liabilities and obligations payable or owing by an obligor to any subordinated creditor, assign or puport to assign to any person the whole or any part of the subordinated liabilities, purport to set off at any time any amount, attempt to obtain repayment or prepayment of principal or payment of any interest, fees or commissions on, or by reference to, any of the subordinated liabilities otherwise than in accordance with the terms of the deed;.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branch (As Security Trustee for Thefinance Parties)
    Transaktionen
    • 02. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. März 2003
    Geliefert am 02. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and any other chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branch (As Security Trustee for Thefinance Parties)
    Transaktionen
    • 02. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Apr. 2002
    Geliefert am 17. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The whole of the property (including uncalled capital) which is may be from time to time comprised in the property and undertaking of the company.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0