FORNO VIVO LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFORNO VIVO LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04318283
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FORNO VIVO LIMITED?

    • (5530) /

    Wo befindet sich FORNO VIVO LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    KROLL LIMITED
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FORNO VIVO LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis25. Feb. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für FORNO VIVO LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    8 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. März 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Sept. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. März 2011

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Sept. 2010

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. März 2010

    6 Seiten4.68

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    17 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Sept. 2008

    14 Seiten2.24B

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288c

    Vorschlag des Verwalters

    32 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    8 Seiten2.16B

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 25. Feb. 2007

    17 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von FORNO VIVO LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Sekretär
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    KEEN, Christian
    The Paddock
    Alverton
    NG13 9PB Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    The Paddock
    Alverton
    NG13 9PB Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish117424240001
    BORG-NEAL, Moira Kathleen
    6 Beaconsfield Road
    HP23 4DP Tring
    Hertfordshire
    Sekretär
    6 Beaconsfield Road
    HP23 4DP Tring
    Hertfordshire
    Irish44812090001
    INGHAM, Michael Harry Peter
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Sekretär
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    British2739650001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Sekretär
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    British145920530001
    LLOYD, Christopher James
    Gossoms 1 Whytingham Road
    HP23 5JN Tring
    Hertfordshire
    Sekretär
    Gossoms 1 Whytingham Road
    HP23 5JN Tring
    Hertfordshire
    British26639240001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    NEWHALL NOMINEES LIMITED
    115 Colmore Row
    B3 3AL Birmingham
    Sekretär
    115 Colmore Row
    B3 3AL Birmingham
    18182520002
    BAKER, Suzanne Louise
    Lincoln House
    Rouse Court
    SL9 0NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Lincoln House
    Rouse Court
    SL9 0NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish35409580006
    BORG-NEAL, Peter James
    9 Akeman Street
    HP23 6AA Tring
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    9 Akeman Street
    HP23 6AA Tring
    Hertfordshire
    United KingdomBritish112253760002
    BROWN, Aaron Maxwell
    Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    5
    Geschäftsführer
    Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    5
    United KingdomBritish98928830002
    BROWN, Stephen John
    17 Mill Road
    SL7 1PX Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    17 Mill Road
    SL7 1PX Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish102228010001
    DAVIES, Philip Michael
    72 Kingswood Road
    SW6 6SS London
    Geschäftsführer
    72 Kingswood Road
    SW6 6SS London
    British84509710001
    FOWLER, Stevan Lloyd
    The Tower House
    Kirkless Hall Clifton
    HD6 4DH Brighouse
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Tower House
    Kirkless Hall Clifton
    HD6 4DH Brighouse
    Yorkshire
    British88380470001
    GRUNNELL, Mark
    Montolieu Gardens
    SW15 6PB London
    3
    Geschäftsführer
    Montolieu Gardens
    SW15 6PB London
    3
    United KingdomBritish94144450002
    HALL, Rufus
    47 Crouch Hall Lane,
    Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Herts
    Geschäftsführer
    47 Crouch Hall Lane,
    Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Herts
    United KingdomBritish231531520001
    JONES, Mark Vincent
    The Hollies
    Hawley Lane, Halebarns
    WA15 0DR Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Hollies
    Hawley Lane, Halebarns
    WA15 0DR Altrincham
    Cheshire
    British84725550002
    LLOYD, Christopher James
    Gossoms 1 Whytingham Road
    HP23 5JN Tring
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Gossoms 1 Whytingham Road
    HP23 5JN Tring
    Hertfordshire
    British26639240001
    MERCURIO, Raffaele
    18 Fairthorn Close
    HP23 4DT Tring
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    18 Fairthorn Close
    HP23 4DT Tring
    Hertfordshire
    Italian83633360001
    PAYNE, Ian Timothy
    Rumbolds
    Spring Lane
    SG9 9QH Cottered
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Rumbolds
    Spring Lane
    SG9 9QH Cottered
    Hertfordshire
    EnglandBritish78974110003
    ROWLINSON, Colin
    Copt Hill Shaw
    Alcocks Lane
    KT20 6BB Kingswood
    Surrey
    Geschäftsführer
    Copt Hill Shaw
    Alcocks Lane
    KT20 6BB Kingswood
    Surrey
    British77454060001
    SCHOOLING, Malcolm David
    53 Steade Road
    S7 1DS Sheffield
    Geschäftsführer
    53 Steade Road
    S7 1DS Sheffield
    EnglandBritish80873200001
    SMALLEY, Timothy John
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    Geschäftsführer
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    United KingdomBritish102593650002
    SYMONDS, Paul
    Willow House
    10a Vicars Close, Biddenham
    MK40 4BG Bedford
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Willow House
    10a Vicars Close, Biddenham
    MK40 4BG Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish80167420001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Hat FORNO VIVO LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Yates opco security and undertaking agreement
    Erstellt am 20. Mai 2005
    Geliefert am 02. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the security is created in favour of the facility agent; and is security for the payment and satisfaction of all the secured liabilities; all estates and interests in any property now owned by it not situated in scotland and all buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery on that property;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for the Finance Parties(The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 02. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 22. Okt. 2004
    Geliefert am 28. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Target group debenture
    Erstellt am 10. Sept. 2004
    Geliefert am 15. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Erstellt am 17. Juni 2003
    Geliefert am 05. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the old post office 69 high street tring hertfordshire t/no: HD285122. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Juni 2003
    Geliefert am 05. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. März 2002
    Geliefert am 12. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £300,000.00 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property, the old post office, 69 high street, tring, herfordshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. März 2002
    Geliefert am 12. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £300,000.00 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat FORNO VIVO LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    27. März 2009Ende der Verwaltung
    27. März 2008Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Simon Jonathan Appell
    Kroll
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Kroll
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    James John Gleave
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DatumTyp
    03. Okt. 2012Aufgelöst am
    27. März 2009Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Simon Jonathan Appell
    Kroll
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Kroll
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    James John Gleave
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0