BIP 2 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BIP 2 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04324504 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BIP 2 LIMITED?
- Veröffentlichung von Verbraucher- und Wirtschaftszeitschriften und -periodika (58142) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich BIP 2 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hartfield House First Floor 41-47 Hartfield Road SW19 3RQ Wimbledon London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BIP 2 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| FRAMESOLVE LIMITED | 19. Nov. 2001 | 19. Nov. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BIP 2 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BIP 2 LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für BIP 2 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Chris Downham als Direktor am 14. März 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt eines Auditors | 2 Seiten | AA03 | ||||||||||
Rücktritt eines Auditors | 2 Seiten | AA03 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kymberley Newton Kingwill als Geschäftsführer am 21. Jan. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kym Kingwill als Sekretär am 21. Jan. 2012 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Joseph als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Joseph als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Kym Kingwill als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Kym Kingwill als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BIP 2 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOWNHAM, Chris | Geschäftsführer | First Floor 41-47 Hartfield Road SW19 3RQ Wimbledon Hartfield House London | England | British | 193594150001 | |||||
| HARRIS, Anthony Charles | Geschäftsführer | Feltham Avenue KT8 9BL East Molesey 12 Surrey Uk | United Kingdom | British | 67943140007 | |||||
| JOSEPH, David | Sekretär | Home Farm, Leicester Road Thornhaugh PE8 6NL Peterborough The Cottages Cambs United Kingdom | British | 99583300001 | ||||||
| KINGWILL, Kym | Sekretär | Hartfield Road Wimbledon SW19 3RQ London 41-47 | British | 157014540001 | ||||||
| NEWBERRY, Clare | Sekretär | 28 Saint Anns Villas W11 4RS London | British | 79423480001 | ||||||
| CORNHILL SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | St Paul's House Warwick Lane EC4M 7BP London | 900023430001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| CHALMIN, Christian Jean | Geschäftsführer | Garden Flat 52 Richmond Hill TW10 6RQ Richmond Surrey | French | 57026110001 | ||||||
| JOSEPH, David | Geschäftsführer | Home Farm Leicester Road PE8 6NL Thornhaugh The Cottages Cambs United Kingdom | United Kingdom | British | 99583300001 | |||||
| KINGWILL, Kymberley Newton | Geschäftsführer | Hartfield Road Wimbledon SW19 3RQ London 41-47 | United Kingdom | British | 2550080002 | |||||
| SAUNDERS, William Alexander | Geschäftsführer | Elmdene 45 West End Lane HA5 1BU Pinner Middlesex | United Kingdom | British | 102673920002 | |||||
| TISSOT, Bertrand | Geschäftsführer | 99 Rue De Lquest FOREIGN Paris 75014 France | French | 80300170001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat BIP 2 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of admission dated 01/07/10 to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 15 december 2006 | Erstellt am 01. Juli 2010 Geliefert am 09. Juli 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Dez. 2006 Geliefert am 22. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 15. Dez. 2006 Geliefert am 22. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Okt. 2004 Geliefert am 29. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 30. Jan. 2002 Geliefert am 07. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0