TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04328016 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Windsor House 42-50 42-50 Victoria Street SW1H 0TL London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
TUBE LINES LIMITED | 28. Jan. 2002 | 28. Jan. 2002 |
2164TH SINGLE MEMBER SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED | 23. Nov. 2001 | 23. Nov. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 08. Mai 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Howard Ernest Carter als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Keith Williams als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Daniel Moylan als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Sir Peter Gerard Hendy am 12. März 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Garnett als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2010 bis 31. März 2011 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O the Company Secretary the Sherard Building Edmund Halley Road Oxford Oxfordshire OX4 4DQ United Kingdom geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 23 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 23 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Wer sind die Geschäftsführer von TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARTER, Howard Earnest | Sekretär | 42-50 Victoria Street SW1H 0TL London Windsor House 42-50 | British | 152621500001 | ||||||
JONES, Martin Patrick William | Sekretär | 42-50 Victoria Street SW1H 0TL London Windsor House 42-50 | British | 152674210001 | ||||||
ALLEN, Stephen David | Geschäftsführer | 42-50 Victoria Street SW1H 0TL London Windsor House 42-50 | England | British | Finance Director | 91156870001 | ||||
CARTER, Howard Ernest | Geschäftsführer | 42-50 Victoria Street SW1H 0TL London Windsor House 42-50 | United Kingdom | British | Gereral Counsel | 115261680003 | ||||
HENDY, Peter Gerard, Sir | Geschäftsführer | 42-50 Victoria Street SW1H 0TL London Windsor House 42-50 | England | British | Commissioner For Transport | 62384480001 | ||||
LING, Elaine Linda Kirby | Sekretär | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | British | 103202830002 | ||||||
SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Sekretär | Meridian House The Crescent YO24 1AW York North Yorkshire | 70053320013 | |||||||
SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Sekretär | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford | 109588620001 | |||||||
SISEC LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001770001 | |||||||
ADAMS, Michael Augustine | Geschäftsführer | Pilgrim Street 5th Floor EC4V 6RN London 11 | England | British | President Civil | 100265760001 | ||||
ADAMS, Michael Augustine | Geschäftsführer | Comforts Place Tandridge Lane RH7 6LW Lingfield Surrey | England | British | Managing Director | 100265760001 | ||||
BAILEY, Michael Cleveland | Geschäftsführer | Pilgrim Street 5th Floor EC4V 6RN London 11 United Kingdom | Canadian | Business Executive | 110217530001 | |||||
BASSILY, Fady Philip | Geschäftsführer | 6 Physic Place Royal Hospital Road SW3 4HQ London | Usa | Senior Vice President | 95885620001 | |||||
BEGG, David Andrew | Geschäftsführer | 67 Victoria Wharf 46 Narrow Street E14 8DD London | England | British | Lecturer | 76645940003 | ||||
CARLISLE, Celia Diana | Geschäftsführer | 163 Portland Road W11 4LR London | United Kingdom | British | Project Finance | 63756390001 | ||||
COPELAND, Ian Christopher | Geschäftsführer | Oakwood One Pine Street Apartment 2002 FOREIGN San Francisco California 94111 Usa | Usa | Managing Director Finance | 80111500002 | |||||
CORBIN, Brian James | Geschäftsführer | 71 Woodwarde Road Dulwich Village SE22 8UN London | British | Business Executive | 87942120001 | |||||
COTTRELL, Keith | Geschäftsführer | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building | England | British | Investment Manager | 88691090003 | ||||
CUNNINGHAM, Anthony | Geschäftsführer | Brafferton YO61 2NZ York The Old Vicarage North Yorkshire United Kingdom | England | British | Company Director | 135811090001 | ||||
DOVE, Robert Wallace | Geschäftsführer | Tara Cavendish Road Saint Georges Hill KT13 0JT Weybridge Surrey | British | Managing Director | 80507460001 | |||||
ELKHOULY, Wael Nabil | Geschäftsführer | 19 Acacia Avenue HA4 8RQ Eastcote Middlesex | Egyptian | Project Development And Financ | 86216370001 | |||||
ENTWISTLE, Richard William | Geschäftsführer | Crossways Crays Pond RG8 7QE Goring Heath Oxfordshire | British | Director | 50174710001 | |||||
ENTWISTLE, Richard William | Geschäftsführer | Crossways Crays Pond RG8 7QE Goring Heath Oxfordshire | British | Director | 50174710001 | |||||
EWELL, Melvyn | Geschäftsführer | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | England | British | Director | 61515760002 | ||||
FENTON, Christopher Victor | Geschäftsführer | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | England | British | Managing Director | 114610580002 | ||||
FIELD, Malcolm David, Sir | Geschäftsführer | 21 Embankment Gardens SW3 4LW London | England | British | Company Director | 74857040002 | ||||
GARNETT, Christopher William Maxwell | Geschäftsführer | 42-50 Victoria Street SW1H 0TL London Windsor House 42-50 | England | British | Director | 120894870001 | ||||
GARTSHORE, Andrew Robert | Geschäftsführer | 6 Jerningham Road Telegraph Hill SE14 5NX London | New Zealander | Business Executive | 87942040001 | |||||
GORDON, Ray | Geschäftsführer | 29 Carrs Meadow Escrick YO19 6JZ York North Yorkshire | British | Chartered Quantity Surveyor | 102379260001 | |||||
GRENFELL, Eric | Geschäftsführer | Pilgrim Street 5th Floor EC4V 6RN London 11 United Kingdom | American | President Bechtel Enterprises | 102348350001 | |||||
HUI, Carol | Geschäftsführer | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | England | British | Lawyer | 144634860001 | ||||
HYDE, Kevin Oliver | Geschäftsführer | 12 Mount Parade YO24 4AB York | British | Director | 66509100002 | |||||
JOHNSON, Robert Nigel | Geschäftsführer | 16 Kirkwell Bishopthorpe YO23 2RZ York Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 57954340003 | ||||
LEO, Jose | Geschäftsführer | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | Spanish | Group Finance Director | 93348510004 | |||||
LEZALA, Andrew Peter | Geschäftsführer | 11 Finch Crescent Mickleover DE3 0TT Derby Derbyshire | British | Chartered Engineer | 85889200001 |
Hat TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Charge by way of assignment | Erstellt am 12. Mai 2004 Geliefert am 27. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of the company's rights in respect of clauses 3 and 4 of the equity subscription agreement dated 12TH may 2004. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge | Erstellt am 12. Mai 2004 Geliefert am 14. Mai 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower to any borrower secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The borrower shares and the issuer shares, rights under the declaration trust, benefits by way of conversion, redemption, bonus, preference option or otherwise in respect of the borrower shares or any of the issuer shares floating charge undertaking and all property assets and rights present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage over shares | Erstellt am 08. Jan. 2003 Geliefert am 09. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from infraco jnp limited to any senior creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares being the 4,499,991 shares in the capital of the borrower issued in the name of the company and all rights moneys benefits and other properties. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment agreement | Erstellt am 31. Dez. 2002 Geliefert am 13. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its rights in respect of clauses 3 (ebl subscription obligations) and 4 (security for ebl subscription obligations) of the equity subscription agreement. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A debenture and share mortgage | Erstellt am 31. Dez. 2002 Geliefert am 10. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of equitable mortgage and fixed charge the shares, by way of charge all rights moneys benefits and other properties which may from time to time accrue or be offered or arise by way of conversion redemption bonus preference option or otherwise in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of the shares. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A floating charge and share mortgage | Erstellt am 31. Dez. 2002 Geliefert am 02. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any senior creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares, all rights moneys benefits and other properties which may from time to time accrue or be offered or arise by way of conversion redemption bonus preference option or otherwise in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of the shares. A first floating charge over the undertaking and all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment | Erstellt am 09. Sept. 2002 Geliefert am 19. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from jubilee rail limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of security the right to receive the amount of up to £11,933,933 (exclusive of value added tax) payable under or in connection with a letter agreement dated 28 august 2002. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0