HOTEL (PL PROPERTY) HOLDING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HOTEL (PL PROPERTY) HOLDING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04330919 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HOTEL (PL PROPERTY) HOLDING LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich HOTEL (PL PROPERTY) HOLDING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Quadrant House, Floor 6 4 Thomas More Square E1W 1YW London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HOTEL (PL PROPERTY) HOLDING LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HOTEL (PL PROPERTY) LIMITED | 20. Dez. 2001 | 20. Dez. 2001 |
| SHELFCO (NO. 2613) LIMITED | 29. Nov. 2001 | 29. Nov. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HOTEL (PL PROPERTY) HOLDING LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HOTEL (PL PROPERTY) HOLDING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2018 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 20. Dez. 2018
| 9 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 20. Dez. 2018
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 20. Dez. 2018
| 8 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 21. Dez. 2018
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Nigel Luck als Geschäftsführer am 11. Mai 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Nigel Luck als Sekretär am 12. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Ernennung von Leonard Kevin Sebastian als Direktor am 22. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 22 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HOTEL (PL PROPERTY) HOLDING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVINGSTONE, Richard John | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | United Kingdom | British | 156147470001 | |||||
| SEBASTIAN, Leonard Kevin | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 | United Kingdom | Swiss | 231200040001 | |||||
| DUDGEON, Peter Maxwell | Sekretär | 41 Links Road KT17 3PP Epsom Surrey | British | 14674480002 | ||||||
| LUCK, Richard Nigel | Sekretär | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | British | 61070930002 | ||||||
| EPS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | 67339580001 | |||||||
| KING, Christopher | Geschäftsführer | 53 Kings Road TW10 6EG Richmond Surrey | United Kingdom | British | 77423330002 | |||||
| KING, Christopher | Geschäftsführer | 6 Jocelyn Road TW9 2TH Richmond Surrey | British | 77423330001 | ||||||
| LINNELL, Richard Frank Hilary | Geschäftsführer | 29 Defoe Avenue TW9 4DS Kew Surrey | British | 69683730001 | ||||||
| LIVINGSTONE, Ian Malcolm | Geschäftsführer | NW1 | United Kingdom | British | 75831270005 | |||||
| LUCK, Richard Nigel | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 | United Kingdom | British | 61070930002 | |||||
| LUCK, Richard Nigel | Geschäftsführer | Herschel Grange Warfield RG42 6AT Bracknell 4 Berkshire | British | 61070930001 | ||||||
| POSER, Daniel Henry | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | United Kingdom | British | 109483830001 | |||||
| SALWAY, Francis William | Geschäftsführer | Nash House 25 Mount Sion TN1 1TZ Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 72491970003 | |||||
| SEBASTIAN, Leonard Kevin Chandran | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | England | Swiss | 127493570001 | |||||
| MIKJON LIMITED | Geschäftsführer | Lacon House 84 Theobald's Road WC1X 8RW London | 72341560001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HOTEL (PL PROPERTY) HOLDING LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel (Pl Property) Holdco Limited | 06. Apr. 2016 | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat HOTEL (PL PROPERTY) HOLDING LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of debenture | Erstellt am 21. Feb. 2003 Geliefert am 05. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings the hilton hotel, park lane, london t/n LN141760. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of debenture | Erstellt am 08. Aug. 2002 Geliefert am 23. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All that freehold land and buildings known as the hilton hotel, park lane, london t/n LN141760. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of debenture | Erstellt am 08. Aug. 2002 Geliefert am 19. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the obligors or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Including f/hold land and buildings known as hilton hotel,park lane,london W1; ln 141760. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Aug. 2002 Geliefert am 14. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All that f/h land and buildings k/a the hilton hotel park lane london W1. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fourth supplemental trust deed | Erstellt am 08. Feb. 2002 Geliefert am 22. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Payment of the principal of and interest on the £200,000,000 10 per cent. First mortgage debenture stock of land securities PLC and all other moneys intended to be secured by the above deed, by the trust deed dated 5/10/88 (the "trust deed") and by deeds supplemental thereto dated 7/10/88, 18/10/88, 26/10/88, 28/10/88, 20/08/91, 18/11/92, 11/10/96, 1/03/01, 6/03/01 and 31/10/01 | |
Kurze Angaben By way of assignment all moneys payable by virtue of any insurance on the mortgaged property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed dated 5 october 1988 and the second supplementall trust deed dated 1 march 2001 | Erstellt am 05. Okt. 1988 Erworben am 08. Feb. 2002 Geliefert am 22. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £200,000,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2030 of land securities PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed and the deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben F/H land and premises now k/a the london hilton on park lane, london (formerly k/a 21-24 and site of 20 park lane, 27-35, 35A and site of hereford street, 1-7 (odd nos) and sites of 9, 11 and 13 stanhope row, 1-8, 8A, 9-16, 18A and c pitts head mews together with the garages, mayfair vaults and part of the site of pitts head mews) being the whole of the land under t/no. LN141760. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0