THE NATURAL RETAIL COMPANY LIMITED

THE NATURAL RETAIL COMPANY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTHE NATURAL RETAIL COMPANY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04331168
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von THE NATURAL RETAIL COMPANY LIMITED?

    • (5227) /

    Wo befindet sich THE NATURAL RETAIL COMPANY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    62 The Broadway
    Ealing
    W5 5JY London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von THE NATURAL RETAIL COMPANY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    THE NATURAL CAFE LIMITED20. Mai 200220. Mai 2002
    GAIA TRADING LTD29. Nov. 200129. Nov. 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE NATURAL RETAIL COMPANY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für THE NATURAL RETAIL COMPANY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Jan. 2011

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Okt. 2010

    5 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    INSOLVENCY:sec of state release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:- removal of liquidator
    21 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Apr. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Okt. 2009

    5 Seiten4.68

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    17 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 27. Aug. 2008

    17 Seiten2.24B

    legacy

    1 Seiten403a

    Vorschlag des Verwalters

    23 Seiten2.17B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    12 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    13 Seiten363s

    legacy

    3 Seiten395

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    5 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von THE NATURAL RETAIL COMPANY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CURRIE, Rachel
    Willow Tree House, Ashendon
    HP18 0HB Aylesbury
    Sekretär
    Willow Tree House, Ashendon
    HP18 0HB Aylesbury
    British81926550001
    CURRIE, Paul Richard
    Willow Tree House
    Ashendon
    HP18 0HB Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Willow Tree House
    Ashendon
    HP18 0HB Aylesbury
    Buckinghamshire
    British75002800001
    GROBIEN, Philip Henning
    Whitewood
    Keepers Walk
    GU25 4RU Virginia Water
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Whitewood
    Keepers Walk
    GU25 4RU Virginia Water
    Berkshire
    EnglandBritish45991130003
    M W DOUGLAS & COMPANY LIMITED
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    900007890001
    HENDERSON, Simon Armstrong
    Old Byre House
    Sydenham Road
    OX39 4LR Sydenham
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Old Byre House
    Sydenham Road
    OX39 4LR Sydenham
    Oxfordshire
    British122976700001
    MANJI, Nazim
    Springwood
    89 Fairmile Lane
    KT11 2DG Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Springwood
    89 Fairmile Lane
    KT11 2DG Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish54553660003
    ZACHARY, Stefan
    Little Moseley House
    Stocking Lane
    HP14 4RE Naphill
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Little Moseley House
    Stocking Lane
    HP14 4RE Naphill
    Buckinghamshire
    British84594060001
    DOUGLAS NOMINEES LIMITED
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HF London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HF London
    900007880001

    Hat THE NATURAL RETAIL COMPANY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Concession fee deposit deed
    Erstellt am 23. Apr. 2007
    Geliefert am 09. Mai 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £10,000.00 due or to become due from the company to
    Kurze Angaben
    Deposit account of £10,000.
    Berechtigte Personen
    • Edward Stanford Limited
    Transaktionen
    • 09. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 27. Nov. 2006
    Geliefert am 08. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £8,375.00 due or to become due from the company to
    Kurze Angaben
    Interest in the sum of £8,375.00.
    Berechtigte Personen
    • Gorsewood Securities Limited
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 22. Sept. 2006
    Geliefert am 29. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    £55,000.00, an interest bearing account (the deposit account), the amount from time to time standing to the credit of the deposit account and all interest credited to the deposit account from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London Governors of the Possessions and Saint Thomas the Apostle as Governors of Ch
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London Governors of the Possessionsrevenues and Goods of the Hospitals of Edward La
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London Governors of the Possessionste King of England the Sixth of Christ Bridewell
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London Governors of the Possessionsrist's Hospital
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 19. Juni 2006
    Geliefert am 27. Juni 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £36,250 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The total deposit sum of £36,250.
    Berechtigte Personen
    • London Property Holdings Limited
    Transaktionen
    • 27. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 05. Mai 2006
    Geliefert am 12. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    £22,500.00.
    Berechtigte Personen
    • Sandpiper Securities Limited
    Transaktionen
    • 12. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 07. Apr. 2006
    Geliefert am 12. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of deposit supplemental to a lease
    Erstellt am 01. Nov. 2005
    Geliefert am 08. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All interest from time to time standing to the credit of an interest bearing account, wherein is held the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • O&T (Marlow) Limited
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 23. Dez. 2004
    Geliefert am 07. Jan. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £15,675.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Obligations and liabilities of the comapny pursuant to the terms of the rent deposit and the lease refered to therein.
    Berechtigte Personen
    • Theodore Constantinescu
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 10. Dez. 2004
    Geliefert am 23. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juni 2003
    Geliefert am 01. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 20. Dez. 2002
    Geliefert am 24. Dez. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The sum of £90,000 together with £15,750 in respect of vat, an interest bearing account in the name of the company and specifically designated "unit 2, no. 216/218 chiswick high road deposit account". The amount from time to time standing to the credit of the deposit account, all interest credited to the deposit account from time to time.
    Berechtigte Personen
    • Bpu Property Investments Limited
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)

    Hat THE NATURAL RETAIL COMPANY LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    28. Feb. 2008Beginn der Verwaltung
    06. Okt. 2008Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Paul Hudson
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praktiker
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Mark Robert Fry
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praktiker
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    2
    DatumTyp
    06. Okt. 2008Beginn der Liquidation
    26. Apr. 2011Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Paul Hudson
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praktiker
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Mark Robert Fry
    32 Cornhill
    London
    EC3B 3LJ
    Praktiker
    32 Cornhill
    London
    EC3B 3LJ

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0