LEAR INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLEAR INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04331523
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LEAR INVESTMENTS LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich LEAR INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    10 Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEAR INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für LEAR INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Beendigung der Bestellung von Matthew Mackenzie Cheyne als Geschäftsführer am 22. Juni 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Charles Anthony Alcock als Geschäftsführer am 06. Apr. 2018

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 26 Red Lion Square London WC1R 4AG zum 10 Queen Street Place London EC4R 1AG am 18. Dez. 2017

    1 SeitenAD01

    Änderung der Details des Direktors für Hugh Macpherson Cameron Fraser am 23. Okt. 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Hugh Macpherson Cameron Fraser am 23. Okt. 2017

    2 SeitenCH01

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Martin Hamlton Croft-Sharland am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Thomas Joseph Pearman am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Thomas Joseph Pearman am 17. Juli 2017

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Andrew Jenkins am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Ms Teresa Laura Harriet Gilchrist am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Hugh Macpherson Cameron Fraser am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Matthew Mackenzie Cheyne am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Charles Anthony Alcock am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Andrew Jenkins am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Änderung der Details des Direktors für Mr Thomas Joseph Pearman am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Thomas Joseph Pearman am 17. Juli 2017

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Teresa Laura Harriet Gilchrist am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Charles Anthony Alcock am 17. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    4 SeitenDS01

    Änderung der Details des Direktors für Hugh Macpherson Cameron Fraser am 01. Jan. 2017

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    15 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von LEAR INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PEARMAN, Thomas Joseph
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Sekretär
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    169836750001
    CROFT-SHARLAND, Richard Martin Hamlton
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish210167330001
    FRASER, Hugh Macpherson Cameron
    Generaal Vetterstraat 72
    1059 Bw Postbus 69122
    1060 CD Amsterdam
    M7 Real Estate Netherlands Bv
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Generaal Vetterstraat 72
    1059 Bw Postbus 69122
    1060 CD Amsterdam
    M7 Real Estate Netherlands Bv
    Netherlands
    NetherlandsBritish157004960004
    GILCHRIST, Teresa Laura Harriet
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish142404820005
    JENKINS, Andrew
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish142929030001
    PEARMAN, Thomas Joseph
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish104558060004
    COOPER, Carl Brendan
    Dam Street
    WS13 6AA Lichfield
    28
    Staffordshire
    Sekretär
    Dam Street
    WS13 6AA Lichfield
    28
    Staffordshire
    British58611760003
    ALCOCK, Charles Anthony
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish141993640001
    CHEYNE, Matthew Mackenzie
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish96872290001
    COOPER, Carl Brendan
    Dam Street
    WS13 6AA Lichfield
    28
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Dam Street
    WS13 6AA Lichfield
    28
    Staffordshire
    United KingdomBritish58611760003
    LAWRENCE, Sharon Lesley
    Dam Street
    WS13 6AA Lichfield
    28
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Dam Street
    WS13 6AA Lichfield
    28
    Staffordshire
    United KingdomBritish71290360002
    SMITH, Andrew Peter
    Dam Street
    WS13 6AA Lichfield
    28
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Dam Street
    WS13 6AA Lichfield
    28
    Staffordshire
    UkBritish75402920003
    STEVENS, Kevin Colin
    No 8 Dukes Mews
    W1U 4ET London
    Geschäftsführer
    No 8 Dukes Mews
    W1U 4ET London
    British17638460006

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für LEAR INVESTMENTS LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    29. Nov. 2016Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen.

    Hat LEAR INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 19. Aug. 2014
    Geliefert am 21. Aug. 2014
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society (The Chargee)
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Juni 2014
    Geliefert am 01. Juli 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Unit 6, lockett road, south lancashire industrial estate, ashton in makerfield, wigan, t/no: GM744875.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 01. Juli 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 10. Juni 2014
    Geliefert am 11. Juni 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    L/H property k/a unit 11 boston court salford t/no GM698117,f/h property k/a pontymister industrial estate pontymister risca t/no CYM100220.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 11. Juni 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 18. Feb. 2014
    Geliefert am 03. März 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    All and whole the subjects at lochshore east industrial estate glengarnock beith title no AYR57199. Heritable subjects at lochshore south industrial estate glenarnock beith title no AYR57190. The subjects at lochshore south industrial estate glenarnock beith title no AYR5173. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 03. März 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 06. Feb. 2014
    Geliefert am 12. Feb. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 06. Feb. 2014
    Geliefert am 12. Feb. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Feb. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 06. Feb. 2014
    Geliefert am 11. Feb. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    F/H frederick house, dukinfield road, hyde t/no GM691091. F/h india mill business centre, darwen t/no LA715687. L/h parts of india mill, bolton road, darwen t/no LA715688. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 11. Feb. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    Debenture
    Erstellt am 22. Aug. 2012
    Geliefert am 30. Aug. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Units 7&8 ffrwdgrech industrial estate, brecon WA760829. 39/39A high street, tring HD358450. 35 and 35A high street, tring HD216457. For details of further properties charged please see form MG01. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • M7 Real Estate LLP
    Transaktionen
    • 30. Aug. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over rent account
    Erstellt am 07. Aug. 2012
    Geliefert am 23. Aug. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Right title and interest in the charged balance being the balance for the time being on the rent account and icludes all interest accrued thereon see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over sale proceeds account
    Erstellt am 07. Aug. 2012
    Geliefert am 23. Aug. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Right title and interest in the charged balance being the balance for the time being on the charged account and icludes all interest accrued thereon see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of rental assignment
    Erstellt am 25. Jan. 2010
    Geliefert am 29. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The rents from any tenant or licensee of the properties, in relation to lochshore east industrial estate glengarnoch beith,t/n AYR57199, lochshore south ind estate beith, t/n AYR57173, lochshore south ind estate glengarnock beith, t/n AYR57190, for details of further properties please refer to form MG01, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 29. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 23. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Jan. 2010
    Geliefert am 27. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a unit 35-36 nine mile point industrial estate cwmfelinfach newport t/no wa 909448 together with all buildings, fixtures (including trade fixtures), fixed plant & machinery thereon, all beneficial interests and rights any shares the benefit of all guarantees indemnities undertakings and warranties.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 18. Jan. 2010
    Geliefert am 27. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of properties charged please refer to form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 13 april 2007 and
    Erstellt am 21. März 2007
    Geliefert am 21. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Units 1-4 imperial park, linwood, paisley t/n ren 110634.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 21. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. März 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Nov. 2006
    Geliefert am 18. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit 15 the alpha centre, armstrong way, great western business park, yate, south gloucestershire t/no. AV168553. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Okt. 2006
    Geliefert am 12. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H units f & h priority enterprise park ty verlon barry and land and buildings to the west of palmerston road barry t/no WA666719 and WA407306. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 12. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Okt. 2006
    Geliefert am 10. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a cirencester business park love lane industrial estate cirencester gloucester t/no GR202233. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Aug. 2006
    Geliefert am 12. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a brecon house william brown close llantarnam industrial park cwmbran t/no CYM202916. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 12. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security presented for registration in scotland on 2 august 2006 and
    Erstellt am 11. Juli 2006
    Geliefert am 16. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The lease between stephen david ellis and helical bar (cl) limited t/n REN99772.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. März 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security presented for registration in scotland on 2 august 2006 and
    Erstellt am 11. Juli 2006
    Geliefert am 16. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The subjects on east side of muirhead mitchelston industrial estate kirkcaldy t/n's FFE39292 and the south side of 1 to 9 (inclusive) midfield road mitchelston industrial estate kirkaldy t/n FFE7589.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. März 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security presented for registration in scotland on 2 august 2006 and
    Erstellt am 11. Juli 2006
    Geliefert am 16. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The subjects shown in the north west side of lenziemill road cumbernauld glasgow t/n DMB78954.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. März 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security presented for registration in scotland on 2 august 2006 and
    Erstellt am 11. Juli 2006
    Geliefert am 16. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Imex spaces business centre (formerly plot 10) broadleys business park stirling t/n STG55244 part of t/n STG48189 and STG39416,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. März 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security presented for registration in scotland on 2 august 2006 and
    Erstellt am 11. Juli 2006
    Geliefert am 16. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The subjects at albion way east kilbride t/n LAN189936.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. März 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security presented for registration in scotland on 2 august 2006 and
    Erstellt am 11. Juli 2006
    Geliefert am 16. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Tennant complex tennant avenue college milton industrial estate east kilbride t/n LAN140675.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. März 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security presented for registration in scotland on 2 august 2006 and
    Erstellt am 11. Juli 2006
    Geliefert am 16. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Blocks 1 2 3 and 5 threave court castlehill industrial estate carluke, t/n LAN25974 and block 4 threave court castlehill industrial estate carluke t/n LAN25975.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. März 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0