LEAR INVESTMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LEAR INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04331523 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LEAR INVESTMENTS LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich LEAR INVESTMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 10 Queen Street Place EC4R 1AG London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEAR INVESTMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LEAR INVESTMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Beendigung der Bestellung von Matthew Mackenzie Cheyne als Geschäftsführer am 22. Juni 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Charles Anthony Alcock als Geschäftsführer am 06. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 26 Red Lion Square London WC1R 4AG zum 10 Queen Street Place London EC4R 1AG am 18. Dez. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Hugh Macpherson Cameron Fraser am 23. Okt. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Hugh Macpherson Cameron Fraser am 23. Okt. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Martin Hamlton Croft-Sharland am 17. Juli 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Thomas Joseph Pearman am 17. Juli 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Thomas Joseph Pearman am 17. Juli 2017 | 1 Seiten | CH03 | ||
Änderung der Details des Direktors für Andrew Jenkins am 17. Juli 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Ms Teresa Laura Harriet Gilchrist am 17. Juli 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Hugh Macpherson Cameron Fraser am 17. Juli 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Matthew Mackenzie Cheyne am 17. Juli 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Charles Anthony Alcock am 17. Juli 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Andrew Jenkins am 17. Juli 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Thomas Joseph Pearman am 17. Juli 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Thomas Joseph Pearman am 17. Juli 2017 | 1 Seiten | CH03 | ||
Änderung der Details des Direktors für Teresa Laura Harriet Gilchrist am 17. Juli 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Charles Anthony Alcock am 17. Juli 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Hugh Macpherson Cameron Fraser am 01. Jan. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 15 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von LEAR INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEARMAN, Thomas Joseph | Sekretär | The Monument Building 11 Monument Street EC3R 8AF London 3rd Floor United Kingdom | 169836750001 | |||||||
| CROFT-SHARLAND, Richard Martin Hamlton | Geschäftsführer | The Monument Building 11 Monument Street EC3R 8AF London 3rd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 210167330001 | |||||
| FRASER, Hugh Macpherson Cameron | Geschäftsführer | Generaal Vetterstraat 72 1059 Bw Postbus 69122 1060 CD Amsterdam M7 Real Estate Netherlands Bv Netherlands | Netherlands | British | 157004960004 | |||||
| GILCHRIST, Teresa Laura Harriet | Geschäftsführer | The Monument Building 11 Monument Street EC3R 8AF London 3rd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 142404820005 | |||||
| JENKINS, Andrew | Geschäftsführer | The Monument Building 11 Monument Street EC3R 8AF London 3rd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 142929030001 | |||||
| PEARMAN, Thomas Joseph | Geschäftsführer | The Monument Building 11 Monument Street EC3R 8AF London 3rd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 104558060004 | |||||
| COOPER, Carl Brendan | Sekretär | Dam Street WS13 6AA Lichfield 28 Staffordshire | British | 58611760003 | ||||||
| ALCOCK, Charles Anthony | Geschäftsführer | The Monument Building 11 Monument Street EC3R 8AF London 3rd Floor United Kingdom | England | British | 141993640001 | |||||
| CHEYNE, Matthew Mackenzie | Geschäftsführer | The Monument Building 11 Monument Street EC3R 8AF London 3rd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 96872290001 | |||||
| COOPER, Carl Brendan | Geschäftsführer | Dam Street WS13 6AA Lichfield 28 Staffordshire | United Kingdom | British | 58611760003 | |||||
| LAWRENCE, Sharon Lesley | Geschäftsführer | Dam Street WS13 6AA Lichfield 28 Staffordshire | United Kingdom | British | 71290360002 | |||||
| SMITH, Andrew Peter | Geschäftsführer | Dam Street WS13 6AA Lichfield 28 Staffordshire | Uk | British | 75402920003 | |||||
| STEVENS, Kevin Colin | Geschäftsführer | No 8 Dukes Mews W1U 4ET London | British | 17638460006 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für LEAR INVESTMENTS LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 29. Nov. 2016 | Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen. |
Hat LEAR INVESTMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 19. Aug. 2014 Geliefert am 21. Aug. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 30. Juni 2014 Geliefert am 01. Juli 2014 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Unit 6, lockett road, south lancashire industrial estate, ashton in makerfield, wigan, t/no: GM744875. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 10. Juni 2014 Geliefert am 11. Juni 2014 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung L/H property k/a unit 11 boston court salford t/no GM698117,f/h property k/a pontymister industrial estate pontymister risca t/no CYM100220. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 18. Feb. 2014 Geliefert am 03. März 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung All and whole the subjects at lochshore east industrial estate glengarnock beith title no AYR57199. Heritable subjects at lochshore south industrial estate glenarnock beith title no AYR57190. The subjects at lochshore south industrial estate glenarnock beith title no AYR5173. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 06. Feb. 2014 Geliefert am 12. Feb. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 06. Feb. 2014 Geliefert am 12. Feb. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 06. Feb. 2014 Geliefert am 11. Feb. 2014 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung F/H frederick house, dukinfield road, hyde t/no GM691091. F/h india mill business centre, darwen t/no LA715687. L/h parts of india mill, bolton road, darwen t/no LA715688. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Aug. 2012 Geliefert am 30. Aug. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Units 7&8 ffrwdgrech industrial estate, brecon WA760829. 39/39A high street, tring HD358450. 35 and 35A high street, tring HD216457. For details of further properties charged please see form MG01. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, fixtures, plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over rent account | Erstellt am 07. Aug. 2012 Geliefert am 23. Aug. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Right title and interest in the charged balance being the balance for the time being on the rent account and icludes all interest accrued thereon see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over sale proceeds account | Erstellt am 07. Aug. 2012 Geliefert am 23. Aug. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Right title and interest in the charged balance being the balance for the time being on the charged account and icludes all interest accrued thereon see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of rental assignment | Erstellt am 25. Jan. 2010 Geliefert am 29. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The rents from any tenant or licensee of the properties, in relation to lochshore east industrial estate glengarnoch beith,t/n AYR57199, lochshore south ind estate beith, t/n AYR57173, lochshore south ind estate glengarnock beith, t/n AYR57190, for details of further properties please refer to form MG01, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Jan. 2010 Geliefert am 27. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a unit 35-36 nine mile point industrial estate cwmfelinfach newport t/no wa 909448 together with all buildings, fixtures (including trade fixtures), fixed plant & machinery thereon, all beneficial interests and rights any shares the benefit of all guarantees indemnities undertakings and warranties. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Jan. 2010 Geliefert am 27. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of properties charged please refer to form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 13 april 2007 and | Erstellt am 21. März 2007 Geliefert am 21. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Units 1-4 imperial park, linwood, paisley t/n ren 110634. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Nov. 2006 Geliefert am 18. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit 15 the alpha centre, armstrong way, great western business park, yate, south gloucestershire t/no. AV168553. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Okt. 2006 Geliefert am 12. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H units f & h priority enterprise park ty verlon barry and land and buildings to the west of palmerston road barry t/no WA666719 and WA407306. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Okt. 2006 Geliefert am 10. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a cirencester business park love lane industrial estate cirencester gloucester t/no GR202233. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. Aug. 2006 Geliefert am 12. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a brecon house william brown close llantarnam industrial park cwmbran t/no CYM202916. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security presented for registration in scotland on 2 august 2006 and | Erstellt am 11. Juli 2006 Geliefert am 16. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The lease between stephen david ellis and helical bar (cl) limited t/n REN99772. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security presented for registration in scotland on 2 august 2006 and | Erstellt am 11. Juli 2006 Geliefert am 16. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The subjects on east side of muirhead mitchelston industrial estate kirkcaldy t/n's FFE39292 and the south side of 1 to 9 (inclusive) midfield road mitchelston industrial estate kirkaldy t/n FFE7589. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security presented for registration in scotland on 2 august 2006 and | Erstellt am 11. Juli 2006 Geliefert am 16. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The subjects shown in the north west side of lenziemill road cumbernauld glasgow t/n DMB78954. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security presented for registration in scotland on 2 august 2006 and | Erstellt am 11. Juli 2006 Geliefert am 16. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Imex spaces business centre (formerly plot 10) broadleys business park stirling t/n STG55244 part of t/n STG48189 and STG39416,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security presented for registration in scotland on 2 august 2006 and | Erstellt am 11. Juli 2006 Geliefert am 16. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The subjects at albion way east kilbride t/n LAN189936. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security presented for registration in scotland on 2 august 2006 and | Erstellt am 11. Juli 2006 Geliefert am 16. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Tennant complex tennant avenue college milton industrial estate east kilbride t/n LAN140675. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security presented for registration in scotland on 2 august 2006 and | Erstellt am 11. Juli 2006 Geliefert am 16. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Blocks 1 2 3 and 5 threave court castlehill industrial estate carluke, t/n LAN25974 and block 4 threave court castlehill industrial estate carluke t/n LAN25975. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0