SGL REALISATIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SGL REALISATIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04332146 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SGL REALISATIONS LIMITED?
- Sonstiges Druckwesen (18129) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich SGL REALISATIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SGL REALISATIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SERVICE GRAPHICS LIMITED | 13. Dez. 2001 | 13. Dez. 2001 |
| BRANDFAST LIMITED | 30. Nov. 2001 | 30. Nov. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SGL REALISATIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Juli 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SGL REALISATIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 31 Seiten | AM23 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 31 Seiten | AM10 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 30 Seiten | AM10 | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 32 Seiten | AM10 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA | 17 Seiten | AM02 | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 3 Seiten | AM06 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 63 Seiten | AM03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Savoy House Savoy Circus London W3 7DA England zum The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG am 08. Feb. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 3 Seiten | AM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Nov. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Clive Jonathan Lovett als Geschäftsführer am 02. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Landry Kouadio Kouakou als Direktor am 02. März 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Bradley Gray als Geschäftsführer am 02. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Katy Bonnor als Geschäftsführer am 02. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Evan Cole als Geschäftsführer am 02. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Robert Armitage als Geschäftsführer am 02. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Daniel Fattal als Sekretär am 02. März 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Juli 2018 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom One Tudor Street London EC4Y 0AH zum Savoy House Savoy Circus London W3 7DA am 12. März 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Notification of Selmerbridge Limited as a person with significant control on 02. März 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SGL REALISATIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOUAKOU, Landry Kouadjo | Geschäftsführer | 32 London Bridge Street SE1 9SG London The Shard | France | French | 244081450001 | |||||
| FATTAL, Daniel | Sekretär | EC4Y 0AH London One Tudor Street United Kingdom | 202308070001 | |||||||
| GARNHAM, Severine Pascale | Sekretär | 20 Lumley Gardens Cheam SM3 8NW Sutton Surrey | British | 73781220002 | ||||||
| HARRIS, Philip Charles | Sekretär | 33 Seething Wells Lane KT6 5NA Surbiton Surrey | British | 1770540003 | ||||||
| WATSON, Michael William | Sekretär | 14 Simms Gardens East Finchley N2 8HT London | British | 73991440001 | ||||||
| WICKS, David William | Sekretär | 30 Palmerston Road SW14 7PZ London | British | 45457620003 | ||||||
| SAME-DAY COMPANY SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 9 Perseverance Works Kingsland Road E2 8DD London | 900000980001 | |||||||
| ARMITAGE, Matthew Robert | Geschäftsführer | Savoy Circus W3 7DA London Savoy House England | United Kingdom | British | 90549730002 | |||||
| BONNOR, Katy | Geschäftsführer | Savoy Circus W3 7DA London Savoy House England | United Kingdom | British | 98571190001 | |||||
| BRIDLE, Nigel | Geschäftsführer | 11 Park Close OX25 4AS Middleton Stoney Oxfordshire | United Kingdom | British,American | 105962030001 | |||||
| CLAYTON, Mark James | Geschäftsführer | EC4Y 0AH London One Tudor Street United Kingdom | United Kingdom | British | 205746130001 | |||||
| COLE, Nicholas Evan | Geschäftsführer | Savoy Circus W3 7DA London Savoy House England | United Kingdom | British | 257121370001 | |||||
| COLE, Nicholas Evan | Geschäftsführer | 1 Searson Close Tallington PE9 4RF Stamford Harvest Cottage Lincolnshire United Kingdom | United Kingdom | British | 155190870001 | |||||
| EDWARDS, Brian Charles | Geschäftsführer | Sequoia Grassy Lane TN13 1PL Sevenoaks Kent | England | British | 16989990002 | |||||
| GALLAGHER, Michael Francis | Geschäftsführer | Alexandra Park Road N22 7UQ London 204 United Kingdom | United Kingdom | British | 177152860001 | |||||
| GRAY, Paul Bradley | Geschäftsführer | Tudor Street EC4Y 0AH London One | United Kingdom | British | 40048450003 | |||||
| GREEN, Michael Sydney | Geschäftsführer | Littleworth House Littleworth Common Road KT10 9UE Esher Surrey | British | 16380620001 | ||||||
| GREEN, Paul Michael | Geschäftsführer | 56 Hendham Road SW17 7DQ London | United Kingdom | British | 47281660003 | |||||
| LOCKLEY, Mark Alexander | Geschäftsführer | The Holloway B48 7QA Rowney Green Edgewood Gables Worcestershire | England | British | 135634330001 | |||||
| LOVETT, Clive Jonathan | Geschäftsführer | Savoy Circus W3 7DA London Savoy House England | England | British | 253002190001 | |||||
| MARTELL, Patrick Neil | Geschäftsführer | Norfolk Mansions Prince Of Wales Drive SW11 4HL London 9 United Kingdom | United Kingdom | British | 158228830001 | |||||
| MORLEY, Raymond Victor | Geschäftsführer | Flat G 10 Thorney Crescent SW11 3TR London | British | 42465790002 | ||||||
| MOSS, Bennett Ingram Harley | Geschäftsführer | 9 The Charter Road IG8 9RD Woodford Green Essex | British | 34524480002 | ||||||
| PARKIN, Stephen John | Geschäftsführer | One Tudor Street EC4Y 0AH London St Ives Plc | United Kingdom | British | 159922450001 | |||||
| REED, Charles Benjamin | Geschäftsführer | Oak End Wagon Way, Loudwater WD3 4JE Rickmansworth Hertfordshire | England | British | 30920640003 | |||||
| REED, Peter Angas | Geschäftsführer | Primrose Cottage Old Weybeards Farm Hill End Road UB9 6LH Harefield Middlesex | United Kingdom | British | 79474470001 | |||||
| WARD, Simon Christopher | Geschäftsführer | Orchard Well Chapel Street Welford On Avon CV37 8QE Stratford Upon Avon Warwickshire | England | British | 63457430005 | |||||
| WICKS, David William | Geschäftsführer | 30 Palmerston Road SW14 7PZ London | British | 45457620003 | ||||||
| WIGGLESWORTH, Lloyd John | Geschäftsführer | Latton Cricklade SN6 6DP Swindon Latton House England | England | British | 128029980001 | |||||
| WILDMAN & BATTELL LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 9 Perseverance Works Kingsland Road E2 8DD London | 900000970001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SGL REALISATIONS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selmerbridge Limited | 02. März 2018 | Savoy Circus W3 7DA London Savoy House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| St Ives Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Tudor Street EC4Y 0AH London One England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat SGL REALISATIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 02. März 2018 Geliefert am 05. März 2018 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge (all assets) | Erstellt am 12. Juli 2006 Geliefert am 01. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge on purchased debts which fail to vest | Erstellt am 12. Juli 2006 Geliefert am 01. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Juli 2006 Geliefert am 27. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 17. Apr. 2003 Geliefert am 06. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £33,959.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The sum of £33,959 in a joint account in the joint names of the chargee and chargor at national westminster bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 26. Feb. 2003 Geliefert am 28. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £6,400.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben A sum standing to the credit of a deposit account opened in the name of the chargee. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 23. Aug. 2002 Geliefert am 29. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £35,250 together with all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The sums standing to the credit of the rent deposit account referred to in the rent deposit deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security trust deed | Erstellt am 19. Dez. 2001 Geliefert am 04. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All secured property: meaning all the covenants, undertakings, charges, assignments and other security interests pursuant to the security documents (as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 19. Dez. 2001 Geliefert am 04. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the deed or the facility agreements | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage all l/h property belonging to the company at the date of the deed including for the avoidance of doubt the lease of units a, b, c, d and e and the car parking spaces osiers road wandsworth london and the lease of part of sarum business park portway salisbury wiltshire; by way of first fixed charge al f/h & l/h property acquired after the date do the deed, all present and future goodwill and uncalled capital, all book debts and other debts, all plant machinery fixtures and all spare parts.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SGL REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0