ALASKA UK BROMLEY LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ALASKA UK BROMLEY LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04332393 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ALASKA UK BROMLEY LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich ALASKA UK BROMLEY LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | One Curzon Street W1J 5HD London England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ALASKA UK BROMLEY LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
INTU BROMLEY LIMITED | 15. Feb. 2013 | 15. Feb. 2013 |
CSC BROMLEY LIMITED | 30. Nov. 2001 | 30. Nov. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ALASKA UK BROMLEY LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ALASKA UK BROMLEY LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Sept. 2019 | 10 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sunil Patel als Geschäftsführer am 30. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Sept. 2018 | 9 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 043323930006 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 28. März 2017
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 13. März 2017
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 7 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 9 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Rücktritt eines Auditors | 2 Seiten | AA03 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Andrew James Meyrick als Direktor am 15. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Susan Marsden als Sekretär am 15. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Hiren Patel als Direktor am 15. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Sunil Patel als Direktor am 15. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Roy Leonard Carter als Sekretär am 15. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Edward Matthew Giles Roberts als Geschäftsführer am 15. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ALASKA UK BROMLEY LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARTER, Roy Leonard | Sekretär | Curzon Street W1J 5HD London One England | 221182830001 | |||||||
MEYRICK, Andrew James | Geschäftsführer | Curzon Street W1J 5HD London One England | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 213008020001 | ||||
PATEL, Hirenkumar | Geschäftsführer | Curzon Street W1J 5HD London One England | United Kingdom | British | Accountant | 253277190001 | ||||
MARSDEN, Susan | Sekretär | 40 Broadway London SW1H 0BU | British | 68599110004 | ||||||
TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||
ABEL, John George | Geschäftsführer | 9 Hutton Gate Hutton Mount CM13 2XA Brentwood Essex | Uk | British | Chartered Surveyor | 14465220002 | ||||
AINSLEY, Jonathan Mark | Geschäftsführer | 4 Locke Road GU30 7DQ Liphook Hampshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 119641880001 | ||||
BADCOCK, Peter Colin | Geschäftsführer | Wilsley Oast Wilsley Green, Angley Road TN17 2LE Cranbrook Kent | England | British | Finance And Operations Directo | 545530002 | ||||
BARTON, Peter Charles | Geschäftsführer | Warren House Shire Lane WD3 5NH Chorleywood Hertfordshire | England | British | Operations Director | 165160480001 | ||||
BOWYER, Katharine Ann | Geschäftsführer | 40 Broadway London SW1H 0BU | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 190760710001 | ||||
BREEDEN, Martin Richard | Geschäftsführer | 21 Bramley Road SM2 7LR Cheam Surrey | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 250543330001 | ||||
CABLE, Richard Malcolm | Geschäftsführer | 47 Peterborough Road Castor PE5 7AX Peterborough The Old Smithy United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 65264230002 | ||||
CHALDECOTT, Kay Elizabeth | Geschäftsführer | 40 Broadway London SW1H 0BU | England | British | Chartered Surveyor | 68694110002 | ||||
ELLIS, Martin David | Geschäftsführer | 40 Broadway London SW1H 0BU | United Kingdom | British | Project Manager | 108375330002 | ||||
ELLIS, Martin David | Geschäftsführer | Netherby Lower Pond Street Duddenhoe End CB11 4UP Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | Project Manager | 108375330002 | ||||
FISCHEL, David Andrew | Geschäftsführer | 40 Broadway London SW1H 0BU | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 8845220002 | ||||
FORD, Hugh Michael | Geschäftsführer | Curzon Street W1J 5HD London One England | United Kingdom | British | General Corporate Counsel | 165108940001 | ||||
GRANT, Kathryn Anne | Geschäftsführer | The White Lodge 16 Fir Grange Avenue KT13 9AR Weybridge Surrey | England | British | Chartered Surveyor | 119649490001 | ||||
KIRBY, Caroline | Geschäftsführer | 40 Broadway London SW1H 0BU | England | British | Chartered Surveyor | 108375400001 | ||||
PATEL, Sunil | Geschäftsführer | Curzon Street W1J 5HD London One England | United Kingdom | British | Finance Director | 54145950002 | ||||
PEREIRA, Trevor | Geschäftsführer | Curzon Street W1J 5HD London One England | United Kingdom | British | Director | 125130130001 | ||||
PEREIRA, Trevor | Geschäftsführer | 42 Castle Road GU15 2DS Camberley Surrey | United Kingdom | British | Director | 125130130001 | ||||
ROBERTS, Edward Matthew Giles, Dr | Geschäftsführer | Curzon Street W1J 5HD London One England | United Kingdom | British | Chartered Accountant/Finance Director | 154029500001 | ||||
SMITH, Aidan Christopher | Geschäftsführer | 50 Wavendon Avenue Chiswick W4 4NS London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 31140320001 | ||||
WARDLE, Philip Duncan | Geschäftsführer | 16 Gartmoor Gardens SW19 6NY London | British | Chartered Surveyor | 95773950001 | |||||
WEIR, Peter | Geschäftsführer | 40 Broadway London SW1H 0BU | England | British | Accountant | 153981370002 | ||||
WOODHOUSE, Loraine | Geschäftsführer | 40 Broadway London SW1H 0BU | England | British | Finance Director | 134205550001 | ||||
COMPANY DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ALASKA UK BROMLEY LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intu Shopping Centres Plc | 06. Apr. 2016 | Broadway SW1H 0BT London 40 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ALASKA UK BROMLEY LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 15. Dez. 2016 Geliefert am 16. Dez. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The headlease relating to the main shopping centre dated 7 december 1993 between the mayor & burgesses of the london borough of bromley (1) and capital & counties PLC (2) with title number SGL570183. The headlease of queen's garden dated dated 26 march 2015 between the mayor & burgesses of the london borough of bromley (1) and intu bromley limited (2) with title number SGL757793. The headlease of walton house dated 28 november 2003 between british airways pension trustees limited (1) and csc bromley (high street) limited (2) with title number SGL649947. The headlease of 91 & 93 high street dated 28 november 2003 between electricity supply nominees limited (1) and csc bromley (high street) limited (2) with title number SGL649840. The headlease of the lift shaft dated 16 june 2003 between cgnu life assurance limited (1) and csc bromley limited (2) with title number SGL652155. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 25. Jan. 2016 Geliefert am 02. Feb. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The leasehold property known as intu bromley, the glades shopping centre and the pavilion leisure centre, high street, bromley BR1 1DN as the same is registered at the land registry with title number SGL570183. To see all charges, please refer to schedule 1 of the charging document attached to this form. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 26. März 2015 Geliefert am 27. März 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The leasehold property known as land at queen's garden adjacent to intu bromley, the glades shopping centre, bromley as the same is comprised in a headlease dated the same date as this charge and made between (1) the mayor and burgesses of the london borough of bromley and (2) the chargor. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental security agreement | Erstellt am 04. Okt. 2006 Geliefert am 09. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h land k/a walton house 93 high street bromley t/no SGL649947. L/h land k/a 91 and 93 high street, bromley t/no SGL649840 and l/h land k/a lift shaft and motor room at 145 high street bromley t/no SGL652155. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 25. Apr. 2006 Geliefert am 03. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a glades shopping centre bromley t/no SGL570183. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement between, among others, the chargor and the agent (as defined therein) | Erstellt am 24. Juni 2002 Geliefert am 03. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The leasehold property known as glades shopping centre, bromley t/no: SGL570183. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat ALASKA UK BROMLEY LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0