ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED

ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04333841
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED?

    • (9999) /

    Wo befindet sich ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hydrex House, Serbert Way
    Portishead
    BS20 7GD Bristol
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HYDREX LIMITED07. März 200207. März 2002
    INGLEBY (1479) LIMITED04. Dez. 200104. Dez. 2001

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 16. Nov. 2011

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2010 bis 30. Juni 2011

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Feb. 2011

    Kapitalaufstellung am 04. Feb. 2011

    • Kapital: GBP 3,309,384
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Carl Mark D'ammassa am 04. Dez. 2010

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Mr Alan James Jordan als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    13 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Andrew Wood als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Wood als Sekretär

    1 SeitenTM02

    legacy

    35 SeitenMG01

    Ernennung von Mr Carl Mark D'ammassa als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Simcox als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    12 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288c

    legacy

    2 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    13 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    18 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten128(4)

    Wer sind die Geschäftsführer von ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    D'AMMASSA, Carl Mark
    Hydrex House, Serbert Way
    Portishead
    BS20 7GD Bristol
    Geschäftsführer
    Hydrex House, Serbert Way
    Portishead
    BS20 7GD Bristol
    United KingdomBritish147037660007
    JORDAN, Alan James
    Hydrex House, Serbert Way
    Portishead
    BS20 7GD Bristol
    Geschäftsführer
    Hydrex House, Serbert Way
    Portishead
    BS20 7GD Bristol
    EnglandIrish150320720001
    SEYMOUR, Paul Richard
    14 Campanula Drive
    Meadow Brook
    NP10 9JG Rogerstone
    Newport
    Sekretär
    14 Campanula Drive
    Meadow Brook
    NP10 9JG Rogerstone
    Newport
    British75293670002
    WOOD, Andrew Simon
    Shaplands
    Stoke Bishop
    BS9 1AY Bristol
    5
    Avon
    United Kingdom
    Sekretär
    Shaplands
    Stoke Bishop
    BS9 1AY Bristol
    5
    Avon
    United Kingdom
    British33951380003
    WOOD, Andrew Simon
    Shaplands
    Stoke Bishop
    BS9 1AY Bristol
    5
    Avon
    United Kingdom
    Sekretär
    Shaplands
    Stoke Bishop
    BS9 1AY Bristol
    5
    Avon
    United Kingdom
    British33951380003
    INGLEBY NOMINEES LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Bevollmächtigter Sekretär
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007860001
    ADDIS, Jonathan Peter
    Park Hill
    B13 8DS Birmingham
    98
    West Midlands
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Park Hill
    B13 8DS Birmingham
    98
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish260439420001
    DAVIES, Brian Thomas
    Woodbridge
    Rockvilla Lane Beachley Road
    NP6 2DR Chepstow
    Gwent
    Geschäftsführer
    Woodbridge
    Rockvilla Lane Beachley Road
    NP6 2DR Chepstow
    Gwent
    United KingdomBritish39854170001
    GALLOWAY, David Allistair
    Moat House
    Chapel Lane
    PO20 8QG West Wittering
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Moat House
    Chapel Lane
    PO20 8QG West Wittering
    West Sussex
    EnglandBritish180591130001
    HUNTER, Richard James Martin
    2 Tirlemont Road
    CR2 6DS South Croydon
    Geschäftsführer
    2 Tirlemont Road
    CR2 6DS South Croydon
    United KingdomBritish94346370001
    LEWIS, Alan Stuart
    Farleigh Road
    Backwell
    BS48 3PE Bristol
    Southfield Farm
    North Somerset
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Farleigh Road
    Backwell
    BS48 3PE Bristol
    Southfield Farm
    North Somerset
    United Kingdom
    EnglandBritish139548580001
    PAYNE, Alan Douglas
    112 Northfield Road
    Kings Norton
    B30 1JG Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    112 Northfield Road
    Kings Norton
    B30 1JG Birmingham
    West Midlands
    British74345940001
    ROGERS, Doug Ernest
    Kiln House
    5 Kiln Lane Dickens Heath Village
    B90 1SF Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Kiln House
    5 Kiln Lane Dickens Heath Village
    B90 1SF Solihull
    West Midlands
    British109970170001
    SEYMOUR, Paul Richard
    14 Campanula Drive
    Meadow Brook
    NP10 9JG Rogerstone
    Newport
    Geschäftsführer
    14 Campanula Drive
    Meadow Brook
    NP10 9JG Rogerstone
    Newport
    British75293670002
    SIMCOX, Andrew James
    Ashley Drive South
    Ashley Heath
    BH24 2JP Ringwood
    53
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ashley Drive South
    Ashley Heath
    BH24 2JP Ringwood
    53
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish41023640002
    WOOD, Andrew Simon
    Shaplands
    Stoke Bishop
    BS9 1AY Bristol
    5
    Avon
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Shaplands
    Stoke Bishop
    BS9 1AY Bristol
    5
    Avon
    United Kingdom
    United KingdomBritish33951380003
    WOOD, Andrew Simon
    Shaplands
    Stoke Bishop
    BS9 1AY Bristol
    5
    Avon
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Shaplands
    Stoke Bishop
    BS9 1AY Bristol
    5
    Avon
    United Kingdom
    United KingdomBritish33951380003
    INGLEBY HOLDINGS LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007850001

    Hat ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 24. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Agent for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 21. März 2006
    Geliefert am 23. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 03. März 2005
    Geliefert am 17. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transaktionen
    • 17. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second supplemental agreement in respect of debenture dated 12 march 2002
    Erstellt am 06. Mai 2003
    Geliefert am 09. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The words "and as furuther amended by way of a supplemental agreement dated 6 may 2003 shall be inserted at the end of the definition of "intercreditor deed". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bridgepoint Capital (Nominees) Limited
    Transaktionen
    • 09. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental agreement in respect of debenture dated 12 march 2002
    Erstellt am 21. Feb. 2003
    Geliefert am 13. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The following amendments shall be made to the debenture the figure "2009" shall be inserted in place of the figure "2008" the words "amended by way of a side letter produced by osborne clarke dated 20 february 2003" shall be inserted at the end of the definition of "intercreditor" the words "the third investor loan notes" shall be inserted after the words "the second investor loan notes" in the definition of "loan notes" the words "the third investor loan notes instrument" shall be inserted after the words "the second investor loan note instrument" in the definition of "loan notes instruments"the following new definitions shall be inserted "the third investor loan notes" means the loan notes constituted by the third investor loan notes instrument "the third investor loan note agreement" means the instrument to be entered into by the company pursuant to clause 3.4 of the investment agreement and pursuant to which £1,000,000 of fixed rate 8.8%-8% secured loan notes 2009 save as amended above the terms of the debenture shall remain full force and effect.
    Berechtigte Personen
    • Bridgepoint Capital (Nominees) Limited
    Transaktionen
    • 13. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. März 2002
    Geliefert am 20. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the noteholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bridgepoint Capital (Nominees) Limited
    Transaktionen
    • 20. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman policy
    Erstellt am 12. März 2002
    Geliefert am 20. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assigns the policy and all sums assured by it and all bonuses and benefitsand all right title and interest in and to the policy :- andrew simcox norwich union pol.no. 7739697EN.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. März 2002
    Geliefert am 20. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0