ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04333841 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hydrex House, Serbert Way Portishead BS20 7GD Bristol |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HYDREX LIMITED | 07. März 2002 | 07. März 2002 |
| INGLEBY (1479) LIMITED | 04. Dez. 2001 | 04. Dez. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2010 bis 30. Juni 2011 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Carl Mark D'ammassa am 04. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Alan James Jordan als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Wood als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Wood als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
legacy | 35 Seiten | MG01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Carl Mark D'ammassa als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Simcox als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 128(4) | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'AMMASSA, Carl Mark | Geschäftsführer | Hydrex House, Serbert Way Portishead BS20 7GD Bristol | United Kingdom | British | 147037660007 | |||||
| JORDAN, Alan James | Geschäftsführer | Hydrex House, Serbert Way Portishead BS20 7GD Bristol | England | Irish | 150320720001 | |||||
| SEYMOUR, Paul Richard | Sekretär | 14 Campanula Drive Meadow Brook NP10 9JG Rogerstone Newport | British | 75293670002 | ||||||
| WOOD, Andrew Simon | Sekretär | Shaplands Stoke Bishop BS9 1AY Bristol 5 Avon United Kingdom | British | 33951380003 | ||||||
| WOOD, Andrew Simon | Sekretär | Shaplands Stoke Bishop BS9 1AY Bristol 5 Avon United Kingdom | British | 33951380003 | ||||||
| INGLEBY NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007860001 | |||||||
| ADDIS, Jonathan Peter | Geschäftsführer | Park Hill B13 8DS Birmingham 98 West Midlands United Kingdom | England | British | 260439420001 | |||||
| DAVIES, Brian Thomas | Geschäftsführer | Woodbridge Rockvilla Lane Beachley Road NP6 2DR Chepstow Gwent | United Kingdom | British | 39854170001 | |||||
| GALLOWAY, David Allistair | Geschäftsführer | Moat House Chapel Lane PO20 8QG West Wittering West Sussex | England | British | 180591130001 | |||||
| HUNTER, Richard James Martin | Geschäftsführer | 2 Tirlemont Road CR2 6DS South Croydon | United Kingdom | British | 94346370001 | |||||
| LEWIS, Alan Stuart | Geschäftsführer | Farleigh Road Backwell BS48 3PE Bristol Southfield Farm North Somerset United Kingdom | England | British | 139548580001 | |||||
| PAYNE, Alan Douglas | Geschäftsführer | 112 Northfield Road Kings Norton B30 1JG Birmingham West Midlands | British | 74345940001 | ||||||
| ROGERS, Doug Ernest | Geschäftsführer | Kiln House 5 Kiln Lane Dickens Heath Village B90 1SF Solihull West Midlands | British | 109970170001 | ||||||
| SEYMOUR, Paul Richard | Geschäftsführer | 14 Campanula Drive Meadow Brook NP10 9JG Rogerstone Newport | British | 75293670002 | ||||||
| SIMCOX, Andrew James | Geschäftsführer | Ashley Drive South Ashley Heath BH24 2JP Ringwood 53 Hampshire United Kingdom | England | British | 41023640002 | |||||
| WOOD, Andrew Simon | Geschäftsführer | Shaplands Stoke Bishop BS9 1AY Bristol 5 Avon United Kingdom | United Kingdom | British | 33951380003 | |||||
| WOOD, Andrew Simon | Geschäftsführer | Shaplands Stoke Bishop BS9 1AY Bristol 5 Avon United Kingdom | United Kingdom | British | 33951380003 | |||||
| INGLEBY HOLDINGS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007850001 |
Hat ROWDEN REALISATIONS 2 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 24. Juni 2010 Geliefert am 08. Juli 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. März 2006 Geliefert am 23. März 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 03. März 2005 Geliefert am 17. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second supplemental agreement in respect of debenture dated 12 march 2002 | Erstellt am 06. Mai 2003 Geliefert am 09. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The words "and as furuther amended by way of a supplemental agreement dated 6 may 2003 shall be inserted at the end of the definition of "intercreditor deed". See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental agreement in respect of debenture dated 12 march 2002 | Erstellt am 21. Feb. 2003 Geliefert am 13. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The following amendments shall be made to the debenture the figure "2009" shall be inserted in place of the figure "2008" the words "amended by way of a side letter produced by osborne clarke dated 20 february 2003" shall be inserted at the end of the definition of "intercreditor" the words "the third investor loan notes" shall be inserted after the words "the second investor loan notes" in the definition of "loan notes" the words "the third investor loan notes instrument" shall be inserted after the words "the second investor loan note instrument" in the definition of "loan notes instruments"the following new definitions shall be inserted "the third investor loan notes" means the loan notes constituted by the third investor loan notes instrument "the third investor loan note agreement" means the instrument to be entered into by the company pursuant to clause 3.4 of the investment agreement and pursuant to which £1,000,000 of fixed rate 8.8%-8% secured loan notes 2009 save as amended above the terms of the debenture shall remain full force and effect. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. März 2002 Geliefert am 20. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the noteholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of keyman policy | Erstellt am 12. März 2002 Geliefert am 20. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Assigns the policy and all sums assured by it and all bonuses and benefitsand all right title and interest in and to the policy :- andrew simcox norwich union pol.no. 7739697EN. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. März 2002 Geliefert am 20. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0