REGENDA LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameREGENDA LIMITED
    UnternehmensstatusUmwandlung / Auflösung
    RechtsformUmwandlung / Auflösung
    Unternehmensnummer 04334057
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von REGENDA LIMITED?

    • (9800) /

    Wo befindet sich REGENDA LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Regenda House
    Enterprise Business Park
    Northgate Close, Horwich
    Boltonbl6 6pq
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von REGENDA LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2010

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für REGENDA LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für REGENDA LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Registrierungsbescheinigung eines Sozialvereins

    CERTIPS

    Verschiedenes

    Form b to convert to i&ps
    1 SeitenMISC

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Convert to i&ps 20/01/2011
    RES13

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2010 ohne Mitgliederliste

    9 SeitenAR01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    52 SeitenAA

    legacy

    6 SeitenMG01

    Beschlüsse

    Resolutions
    5 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschlüsse

    Dir empowered / sect 175 01/03/2010
    RES13

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2009 ohne Mitgliederliste

    6 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Stephen Barrett Conquer am 09. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Stephen Howse am 09. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Derek Hancock am 09. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Robin Barry Burman am 09. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Bernard James Gallagher am 09. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Brown am 09. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Ms Catherine Lynagh am 09. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von John Thomson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    52 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von REGENDA LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    VINCENT, Julie Anne
    42 Norfolk Road
    L31 5NZ Maghull
    Merseyside
    Sekretär
    42 Norfolk Road
    L31 5NZ Maghull
    Merseyside
    British95635910001
    BROWN, Michael
    The Beeches 4 Orchard End
    Great Eccleston
    PR3 0YW Blackpool
    Lancashire
    Geschäftsführer
    The Beeches 4 Orchard End
    Great Eccleston
    PR3 0YW Blackpool
    Lancashire
    United KingdomBritish62761860001
    BURMAN, Robin Barry
    446 Barlow Moor Road
    Chorlton
    M21 0BQ Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    446 Barlow Moor Road
    Chorlton
    M21 0BQ Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritish102451800001
    CONQUER, Stephen Barrett
    6 Broomfield Close
    Chelford
    SK11 9SL Macclesfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    6 Broomfield Close
    Chelford
    SK11 9SL Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritish24337060001
    GALLAGHER, Bernard James
    Lingmoor Road
    Heaton
    BL1 5EA Bolton
    10
    Greater Manchester
    Geschäftsführer
    Lingmoor Road
    Heaton
    BL1 5EA Bolton
    10
    Greater Manchester
    United KingdomBritish138002910001
    HANCOCK, Derek
    Shropshire Road
    Failsworth
    M35 0GU Manchester
    9
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Shropshire Road
    Failsworth
    M35 0GU Manchester
    9
    United Kingdom
    EnglandBritish134872680001
    HOWSE, Stephen
    Birch Lane
    SK16 4AJ Dukinfield
    43
    Gtr Manchester
    Geschäftsführer
    Birch Lane
    SK16 4AJ Dukinfield
    43
    Gtr Manchester
    United KingdomBritish137878690001
    LYNAGH, Catherine Elizabeth
    Gaddum Road
    M20 6SZ Manchester
    6
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gaddum Road
    M20 6SZ Manchester
    6
    United Kingdom
    EnglandBritish135372780001
    HARPER, Anthony James
    89 Grappenhall Road
    Stockton Heath
    WA4 2AR Warrington
    Cheshire
    United Kingdom
    Sekretär
    89 Grappenhall Road
    Stockton Heath
    WA4 2AR Warrington
    Cheshire
    United Kingdom
    British141656620001
    OLIVER, Robert Vivian
    29 Barnes Green
    CH63 9LU Spital
    Merseyside
    Sekretär
    29 Barnes Green
    CH63 9LU Spital
    Merseyside
    British84551340001
    BARKER, William Ernest
    17 Woodlands Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 5DD Cheadle
    Cheshire
    Geschäftsführer
    17 Woodlands Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 5DD Cheadle
    Cheshire
    British13071500001
    CHADWICK, Robert
    20 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DG Chester
    Cheshire
    Geschäftsführer
    20 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DG Chester
    Cheshire
    EnglandBritish119286210001
    COFFEY, Peter
    19 Heath Lane
    Little Sutton
    CH66 5NN Ellesmere Port
    Cheshire
    Geschäftsführer
    19 Heath Lane
    Little Sutton
    CH66 5NN Ellesmere Port
    Cheshire
    EnglandBritish83395490001
    CRAWFORD, Helen
    41 Guffitts Rake
    Meols
    CH47 7AJ Wirral
    Cheshire
    Geschäftsführer
    41 Guffitts Rake
    Meols
    CH47 7AJ Wirral
    Cheshire
    British83395500001
    FENTON, Lyn
    Hawksview
    Division Lane
    FY4 5EA Blackpool
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Hawksview
    Division Lane
    FY4 5EA Blackpool
    Lancashire
    EnglandBritish30695870002
    GIBAUD, Christopher Roy
    Nursery House
    Knowsley Park, Prescot
    L34 7HD Liverpool
    Geschäftsführer
    Nursery House
    Knowsley Park, Prescot
    L34 7HD Liverpool
    British30145700004
    HARPER, Anthony James
    89 Grappenhall Road
    Stockton Heath
    WA4 2AR Warrington
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    89 Grappenhall Road
    Stockton Heath
    WA4 2AR Warrington
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish141656620001
    ISAACS, Peter John
    Inglewood Hall Lane
    Great Eccleston
    PR3 0XN Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Inglewood Hall Lane
    Great Eccleston
    PR3 0XN Preston
    Lancashire
    EnglandBritish28816860001
    MARRINGTON, Anthony
    24 Thomas Street
    Lees
    OL4 5BU Oldham
    Geschäftsführer
    24 Thomas Street
    Lees
    OL4 5BU Oldham
    British34440080001
    PARKINSON, Fran
    9 Cheltenham Avenue
    L17 2AR Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    9 Cheltenham Avenue
    L17 2AR Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritish90559240001
    RAPLEY, Bronwen
    23 Locksley Close
    Heaton Norris
    SK4 2LW Stockport
    Geschäftsführer
    23 Locksley Close
    Heaton Norris
    SK4 2LW Stockport
    British83205890001
    RATHBONE, Mark Edward
    The Gates
    Church Street
    SY14 8PD Malpas
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Gates
    Church Street
    SY14 8PD Malpas
    Cheshire
    EnglandBritish48446280002
    ROGERSON, John Joseph
    Mill Cottage
    Parkgate
    DG1 3LY Dumfries
    Dumfriesshire
    Geschäftsführer
    Mill Cottage
    Parkgate
    DG1 3LY Dumfries
    Dumfriesshire
    United KingdomBritish102157790001
    THOMSON, John James
    13 Thornley Park Road
    Grotton
    OL4 5QT Oldham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    13 Thornley Park Road
    Grotton
    OL4 5QT Oldham
    Lancashire
    EnglandBritish32351900001
    WHITE, Melvin
    26 Macdona Drive
    West Kirby
    CH48 3JD Wirral
    Geschäftsführer
    26 Macdona Drive
    West Kirby
    CH48 3JD Wirral
    British75485930002

    Hat REGENDA LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Sub-charge
    Erstellt am 03. Juni 2010
    Geliefert am 19. Juni 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £70,000,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Right, title and interest from time to time in, or and under the charitable subsidiary fixed charge and any present and future asset referred to in clause 3.1 or 3.1 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transaktionen
    • 19. Juni 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Sub-charge
    Erstellt am 31. März 2009
    Geliefert am 17. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £70 million due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Charitable subsidiary fixed charge between wyre housing association limited as chargor and regenda limited as chargee dated 31 march 2009.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transaktionen
    • 17. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    An assignment
    Erstellt am 22. Aug. 2008
    Geliefert am 28. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other principal obligor to the security trustee or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in to and under each of the present and future assigned documents and any amount becoming payable.. Fixed charges in to and under any relevant present and future asset of the assignment see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Sub-charge
    Erstellt am 02. Mai 2008
    Geliefert am 10. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other principal obligor to the security trustee or any of the beneficiaries (or any person on behalf of any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the chargor's right title and interest from time to time in,to and under the charitable subsidiary fixed charges see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 10. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Sub-charge
    Erstellt am 09. Aug. 2005
    Geliefert am 16. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other principal obligor to the chargee or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in to and under the charitable subsidiary fixed charges. Assigns all right title and interest in to and under each of the assigned documents and any amount becoming payable to it pursuant thereto and by way of fixed charge all right title and interest in to and under any relevant present and future asset and any amount payable to it pursuant thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Sub-charge
    Erstellt am 24. März 2005
    Geliefert am 05. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor or any other principal obligor to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the beneficiaries (or any person on behalf of any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Charges the right, title and interest in, to and under the charitable subsidiary fixed charges; assigns the right, title and interest in, to and under each of the present and future assigned documents and charges the right, title and interest in, to and under any relevant present and future asset. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Sub-charge
    Erstellt am 24. März 2005
    Geliefert am 05. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor or any other principal obligor to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the beneficiaries (or any person on behalf of any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Charges the right, title and interest in, to and under the charitable subsidiary fixed charges; assigns the right, title and interest in, to and under each of the present and future assigned documents and charges the right, title and interest in, to and under any relevant present and future asset. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment
    Erstellt am 24. März 2005
    Geliefert am 05. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor or any other principal obligor to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the beneficiaries (or any person on behalf of any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assigns the right, title and interest in, to and under each of the present and future assigned documents and charges the right, title and interest in, to and under any relevant present and future asset. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 24. März 2005
    Geliefert am 05. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor or any other principal obligor to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the beneficiaries (or any person on behalf of any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Floating charge the undertaking and assets whatsoever and wheresoever. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0