NEW NT HOLDCO LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NEW NT HOLDCO LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04334392 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NEW NT HOLDCO LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich NEW NT HOLDCO LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Cannon Place 78 Cannon Street EC4N 6AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NEW NT HOLDCO LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PRECIS (2161) LIMITED | 05. Dez. 2001 | 05. Dez. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NEW NT HOLDCO LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für NEW NT HOLDCO LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für NEW NT HOLDCO LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 47 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Jonathan Peter Doberman als Direktor am 04. Sept. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nestor Augusto Castillo Borrero als Geschäftsführer am 04. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Biif Corporate Services Limited am 01. Juli 2015 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Dundas & Wilson Northwest Wing Bush House Aldwych London WC2B 4EZ zum Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF am 01. Juli 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Nestor Augusto Castillo Borrero als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Forrest als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Forrest am 21. Mai 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Forrest am 11. Nov. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Forrest am 09. Okt. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Dundas & Wilson North West Wing Bush House Aldwych London WC2B 4EZ* am 27. Aug. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 51 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Biif Corporate Services Limited am 04. Sept. 2012 | 2 Seiten | CH02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Biif Corporate Services Limited am 04. Sept. 2012 | 2 Seiten | CH02 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Infrastructure Managers Limited am 26. Feb. 2013 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Biif Corporate Services Limited am 04. Sept. 2012 | 2 Seiten | CH02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O C/O, Law Debenture Law Debenture Fifth Floor 100 Wood Street London EC2V 7EX* am 04. Sept. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NEW NT HOLDCO LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED | Sekretär | Floor 11 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 2nd United Kingdom |
| 128530180002 | ||||||||||
| DOBERMAN, Jonathan Peter | Geschäftsführer | Palace Street SW1E 5JD London 16 United Kingdom | United Kingdom | British | 201234400001 | |||||||||
| BIIF CORPORATE SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place United Kingdom |
| 138240210001 | ||||||||||
| NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | Sekretär | 76 George Street EH2 3BU Edinburgh | 94907480001 | |||||||||||
| NOBLE PARTNERSHIP LIMITED | Sekretär | 76 George Street EH2 3BU Edinburgh | 86014010001 | |||||||||||
| OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Level 1 Exchange House Primrose Stret EC2A 2HS London | 900019420001 | |||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| CASTILLO BORRERO, Nestor Augusto | Geschäftsführer | 16 Palace Street SW1E 5JD London 3i United Kingdom | England | British | 182601420001 | |||||||||
| CLARKE, Laurence Seymour | Geschäftsführer | Churchill Place E14 5HP London Barclays Bank Plc, 1 | England | British | 138241960001 | |||||||||
| FORREST, Michael | Geschäftsführer | c/o Dundas & Wilson Aldwych WC2B 4EZ London Northwest Wing Bush House United Kingdom | United Kingdom | British | 169634490002 | |||||||||
| MCCULLOCH, Paul | Geschäftsführer | 33 Southwood Avenue Highgate N6 5SA London | British | 101810930001 | ||||||||||
| MCDONAGH, John | Geschäftsführer | 30 St Botolph's Road Sevenoaks TN13 3AG Kent | British | 116580030002 | ||||||||||
| MIDDLETON, Nigel Wythen | Geschäftsführer | The Cottage 198 High Molewood SG14 2PJ Hertford | United Kingdom | British | 85320540001 | |||||||||
| PHILIPSZ, Joseph Eugene | Geschäftsführer | 3 Blinkbonny Grove EH4 3HH Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British,Irish | 83107910002 | |||||||||
| RAY, Alastair Graham | Geschäftsführer | Flat 120, Globe Wharf 205, Rotherhithe Street SE16 5EQ London | British | 100818970001 | ||||||||||
| RYAN, Michael Joseph | Geschäftsführer | Central Building 3 Matthew Parker Street SW1H 9NE London Apartment 42, | United Kingdom | Irish | 77999320003 | |||||||||
| SCOTT-BARRETT, Nicholas Huson | Geschäftsführer | Gatehouse Farm Crown Lane, Ardleigh CO7 7QZ Colchester | British | 59658050001 | ||||||||||
| PEREGRINE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Level 1 Exchange House Primrose Street EC2A 2HS London | 900019410001 |
Hat NEW NT HOLDCO LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 28. Juli 2011 Geliefert am 10. Aug. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of confirmation to security agreement | Erstellt am 19. Dez. 2007 Geliefert am 28. Dez. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the borrowers to the chargee and the senior creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares and related rights floating charge all undertaking property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of confirmation to debenture | Erstellt am 19. Dez. 2007 Geliefert am 28. Dez. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the borrowers to the chargee and the senior creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of confirmation | Erstellt am 09. Nov. 2007 Geliefert am 23. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge all sums now or hereafter standing to the credit of any bank account,all book debts and other debts and other moneys,goodwill. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of confirmation | Erstellt am 09. Nov. 2007 Geliefert am 23. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of confirmation | Erstellt am 21. Dez. 2006 Geliefert am 05. Jan. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the borrowers to the chargee and the senior creditors or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares in new nt limited, and the related rights meaning all rights to dividends and other distributions paid or payable and all stocks, shares or other securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of confirmation | Erstellt am 21. Dez. 2006 Geliefert am 05. Jan. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the borrowers to the chargee and the senior creditors or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all sums standing to the credit of any bank account and all interest and other accruals, book debts, goodwill, uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 02. Jan. 2003 Geliefert am 11. Jan. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the borrowers to the chargee and the senior creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares and the related rights. By way of floating charge all its undertakings and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Jan. 2003 Geliefert am 11. Jan. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the borrowers to the chargee and the senior creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0