PROLOGIS GRANGE PARK PLOT 4 ZONE A (NO.2) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | PROLOGIS GRANGE PARK PLOT 4 ZONE A (NO.2) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04334619 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PROLOGIS GRANGE PARK PLOT 4 ZONE A (NO.2) LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich PROLOGIS GRANGE PARK PLOT 4 ZONE A (NO.2) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Prologis House, Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AH Solihull England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PROLOGIS GRANGE PARK PLOT 4 ZONE A (NO.2) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PROLOGIS GRANGE PARK PLOT 4 ZONE A (NO.2) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Donald Griffiths als Geschäftsführer am 10. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul David Weston als Direktor am 01. Nov. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Monkspath Hall Road Solihull West Midlands B90 4FY zum Prologis House, Blythe Gate Blythe Valley Park Solihull B90 8AH am 30. Aug. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Prologis Uk Limited as a person with significant control on 20. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Cessation of Prologis Inc as a person with significant control on 20. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Nicholas David Mayhew Smith am 21. Sept. 2016 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Donald Griffiths am 21. Aug. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PROLOGIS GRANGE PARK PLOT 4 ZONE A (NO.2) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMITH, Nicholas David Mayhew | Sekretär | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AH Solihull Prologis House, England | British | 149077230001 | ||||||
SMITH, Nicholas David Mayhew | Geschäftsführer | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AH Solihull Prologis House, England | England | British | Lawyer | 127095010001 | ||||
WESTON, Paul David | Geschäftsführer | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AH Solihull Prologis House, England | England | British | Chartered Surveyor | 139192210001 | ||||
SMITH, Nicholas David Mayhew | Sekretär | Holland Avenue Knowle B93 9DW Solihull 9 West Midlands | British | 149077610001 | ||||||
STEPHENSON, Mark William | Sekretär | 3 Spring Meadows Close Bilbrook WV8 1GJ Codsall Staffordshire | British | 82815550001 | ||||||
WINFIELD, Corin Robert | Sekretär | 24 Queens Avenue Shirley B90 2NT Solihull West Midlands | British | 61906590002 | ||||||
HSE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 67382580006 | |||||||
GRIFFITHS, Andrew Donald | Geschäftsführer | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AH Solihull Prologis House, England | United Kingdom | British | Managing Director | 56528380010 | ||||
HODGE, Paul Antony | Geschäftsführer | 89 Manor Road Dorridge B93 8TT Solihull West Midlands | British | Company Director | 61906560002 | |||||
LEWIS, Mark Andrew | Geschäftsführer | 169 Longdon Road Knowle B93 9HY Solihull Penn Fields | England | British | Financial Controller | 135597890002 | ||||
READ, Jonathan Charles | Geschäftsführer | 6 Prospect Lane B91 1HJ Solihull West Midlands | England | British | Accountant | 66338430001 | ||||
HSE DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London England | 73774730002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PROLOGIS GRANGE PARK PLOT 4 ZONE A (NO.2) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | 20. Apr. 2016 | St Paul Street Suite 820 MD 21202 Baltimore 7 Maryland Usa | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Prologis Uk Limited | 20. Apr. 2016 | Monkspath Hall Road Shirley B90 4FY Solihull 1 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat PROLOGIS GRANGE PARK PLOT 4 ZONE A (NO.2) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A supplemental deed relating to a debenture dated 5TH march 2002 | Erstellt am 28. Mai 2002 Geliefert am 11. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities due or to become due from the legal assetco guarantor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right,title and interest in any freehold,leasehold or imovable property and any buildings,fixtures,fittings,fixed plant and machinery thereon; the proceeds of sale and all rights under any licence,agreement for sale or agreement for lease and all other rights,benefits,claims,contracts,remedies,etc and any moneys and proceeds paid thereunder; see form 395 for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 05. März 2002 Geliefert am 20. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the legal assetco guarantor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Part of the f/h lying to the south west of quinton road courteenhall south northamptonshire t/n NN223352 currently part of t/n NN200973 and any building fixture fittings fixed plant or machinery. By way of legal mortgage all the legal assetco guarantor's right title and interest from time to time in the mortgaged property other than any of the related rights in respect of the mortgaged property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 05. März 2002 Geliefert am 20. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the legal assetco guarantor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage all the legal assetco guarantor's right title and interest from time to time in the mortgaged property other than any of the related rights in respect of the mortgaged property. All of its right title and interest from time to time in and to the proceeds of any insurance policy and all related rights and all agreements, contracts, deeds, licences, undertaking, guarantees, covenants, warranties, representations and other documents. By way of first fixed charge all its charge all its present and future rights title and interest in the accounts, intellectual property, allmonetary claims and by way of first floating charge the whole of the legal assetco guarantor's undertaking and assets present and future.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0