PIMLICO NO 2 UK LIMITED
Überblick
Unternehmensname | PIMLICO NO 2 UK LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04335114 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PIMLICO NO 2 UK LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich PIMLICO NO 2 UK LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 40 Craven Street Charing Cross WC2N 5NG London United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PIMLICO NO 2 UK LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
DV3 PIMLICO NO.2 UK LIMITED | 19. Sept. 2003 | 19. Sept. 2003 |
TRIBECA PROPERTY PIMLICO NO. 2 UK LIMITED | 28. Mai 2002 | 28. Mai 2002 |
DELANCEY 065 LIMITED | 05. Dez. 2001 | 05. Dez. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PIMLICO NO 2 UK LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PIMLICO NO 2 UK LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Aidan Brooks als Geschäftsführer am 24. Juni 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 17 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Aidan Brooks am 21. Juni 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sovereign Directors Limited am 05. Dez. 2010 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Sovereign Directors Limited am 05. Dez. 2010 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AF am 22. Okt. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 14 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 12 Seiten | 395 |
Wer sind die Geschäftsführer von PIMLICO NO 2 UK LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOVEREIGN DIRECTORS LIMITED | Sekretär | Suite 2b Mansion House 143 Main Street FOREIGN Gibraltar Gibraltar |
| 44068420001 | ||||||||||
DENTITH, Diane | Geschäftsführer | Victoria Road Douglas IM2 4AS Isle Of Man The Poplars | Isle Of Man | British | Chartered Secretary | 214914010001 | ||||||||
SOVEREIGN DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | Suite 2b Mansion House 143 Main Street FOREIGN Gibraltar Gibraltar |
| 44068420001 | ||||||||||
MOSS, Andrew Graham | Sekretär | 244 Willesden Lane NW2 5RE London | British | Chartered Accountant | 4573140002 | |||||||||
DV3 ADMINISTRATION UK 1 LIMITED | Sekretär | 6th Floor Lansdowne House Berkeley Square W1J 6ER London | 96823770002 | |||||||||||
PORTMAN ADMINISTRATION 1 LIMITED | Sekretär | 40 Portman Square W1H 0AA London | 93189540001 | |||||||||||
WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||||||
BROOKS, Aidan | Geschäftsführer | North Circular Road Limerick Portland House County Limerick Republic Of Ireland | United Kingdom | Irish | Company Director | 158415700001 | ||||||||
EMMETT, Graham Anthony Johnathan | Geschäftsführer | Rushmead Leigh Place KT11 2HL Cobham Surrey | British | Finance Director | 66041940002 | |||||||||
GOSWELL, Paul Jonathan | Geschäftsführer | Mulberry Lodge Mill Hill Barnes SW13 0HS London | United Kingdom | British | Surveyor | 60475780002 | ||||||||
HADEN SCOTT, Timothy | Geschäftsführer | 6 Russell Hill CR8 2JA Purley Surrey | British | Property Investment | 63220740001 | |||||||||
MOSS, Andrew Graham | Geschäftsführer | 244 Willesden Lane NW2 5RE London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 4573140002 | ||||||||
RITBLAT, James William Jeremy | Geschäftsführer | 24 St Petersburgh Place W2 4LB London | England | British | Company Director | 38424950003 | ||||||||
WAGMAN, Colin Barry | Geschäftsführer | North Lodge 25 Ringwood Avenue N2 9NT London | United Kingdom | British | Company Director | 39329840001 | ||||||||
DV3 ADMINISTRATION UK 1 LIMITED | Geschäftsführer | 6th Floor Lansdowne House Berkeley Square W1J 6ER London | 96823770002 | |||||||||||
DV3 ADMINISTRATION UK 2 LIMITED | Geschäftsführer | 6th Floor Lansdowne House Berkeley Square W1J 6ER London | 111665780001 | |||||||||||
WATERLOW NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Hat PIMLICO NO 2 UK LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 09. Okt. 2007 Geliefert am 19. Okt. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The properties listed in schedule 2 of T. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 06. Apr. 2006 Geliefert am 19. Apr. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors and/or the beneficiary to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H land and buildings k/a victoria bus garage, gillingham street, london t/no NGL826335, all plant and machinery, book and other debts and all rental income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 06. Apr. 2006 Geliefert am 19. Apr. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each nominee and/or the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 12. Sept. 2003 Geliefert am 26. Sept. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0