LITCOMP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LITCOMP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04336531 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LITCOMP LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich LITCOMP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 14 Park Row NG1 6GR Nottingham England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LITCOMP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LITCOMP PLC | 07. Dez. 2001 | 07. Dez. 2001 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LITCOMP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LITCOMP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2019 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for Torridon Capital Limited as a person with significant control on 01. Nov. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Paul Anthony Lavender am 22. Juli 2019 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Anthony Lavender am 22. Juli 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stella Panu als Geschäftsführer am 08. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Newton Chambers Newton Business Park Isaac Newton Way Grantham Lincolnshire NG31 9RT zum 14 Park Row Nottingham NG1 6GR am 01. Nov. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jason Andrew Smart als Geschäftsführer am 05. Juli 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 14 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2016 | 16 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 15 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LITCOMP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVENDER, Paul Anthony | Sekretär | Park Row NG1 6GR Nottingham 14 England | British | 1936290001 | ||||||
| LAVENDER, Paul Anthony | Geschäftsführer | Park Row NG1 6GR Nottingham 14 England | England | British | 1936290001 | |||||
| ROBERTS, Thomas Ian | Sekretär | Old Sharrow Head House 311 Cemetery Road S11 8FS Sheffield South Yorkshire | British | 38222760005 | ||||||
| COLLINS, Christopher Francis | Geschäftsführer | Portland House Glacis Road Gibraltor 115 | Gibraltar | British | 158225470001 | |||||
| DAVID, Raymond Thurston | Geschäftsführer | 14 Bamford Road BR1 5QR Bromley Kent | British | 82671070001 | ||||||
| NEMETH, Cyril, Dr | Geschäftsführer | 1 Langford Place NW8 0LJ London | United Kingdom | British | 38310310001 | |||||
| PANU, Stella | Geschäftsführer | c/o Maven Capital Partners Uk Llp 9-13 St. Andrew Street EC4A 3AF London 5th Floor | United Kingdom | British | 116910630001 | |||||
| ROBERTS, Thomas Ian | Geschäftsführer | Old Sharrow Head House 311 Cemetery Road S11 8FS Sheffield South Yorkshire | England | British | 38222760005 | |||||
| SMART, Jason Andrew | Geschäftsführer | Main Street Honington NG32 2PG Grantham Hall Farm Lincs | England | British | 65005610005 | |||||
| SMITH, Douglas Andrew | Geschäftsführer | Tweed Lodge Kerfield EH45 8LY Peebles | Scotland | British | 426460001 | |||||
| WIGGLESWORTH, Jack | Geschäftsführer | Flat 3 And Flat 4 Deacons Heights Barnet Lane Elstree WD6 3QY Borehamwood Hertfordshire | United Kingdom | British | 13177400001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LITCOMP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torridon Capital Limited | 06. Apr. 2016 | Park Row NG1 6GR Nottingham 14 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat LITCOMP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of assignment of life policy | Erstellt am 22. Nov. 2010 Geliefert am 24. Nov. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Insurance policy 5971-2TA-dys over the life of jason smart. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Nov. 2010 Geliefert am 24. Nov. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or the holders of the loan notes on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over cash account | Erstellt am 20. Feb. 2006 Geliefert am 21. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and or the holders of 3,605,000 10% convertible loan notes on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The account, account number 1060261. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 10. Jan. 2006 Geliefert am 17. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares | Erstellt am 16. Nov. 2005 Geliefert am 05. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge all shares all related rights any dividend or interes t paid in relation to any of the shares and any rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Nov. 2005 Geliefert am 05. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the holders of the loan stock to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Nov. 2004 Geliefert am 24. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. März 2004 Geliefert am 22. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating | Erstellt am 30. Juni 2003 Geliefert am 17. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third party charge of deposit | Erstellt am 28. Feb. 2002 Geliefert am 15. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from perfect consulting limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The deposit initially of £185,000 credited to account designation 21754547 with the bank and any addition to that deposit and any deposit from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from or out of such initial deposit or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0