BROOKHAIL LAND LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBROOKHAIL LAND LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04337514
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BROOKHAIL LAND LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich BROOKHAIL LAND LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    5th Floor
    89 New Bond Street
    W1S 1DA London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BROOKHAIL LAND LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BROOKHAIL LAND LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für BROOKHAIL LAND LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 05. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2013

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Jan. 2014

    Kapitalaufstellung am 06. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2012

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Alan Landesberg als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2011

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    9 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Alan Landesberg am 18. Aug. 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2010

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    9 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 89 New Bond Street London W1S 1DA England* am 21. Jan. 2011

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 1 Conduit Street London W1S 2XA* am 01. Juni 2010

    1 SeitenAD01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Wer sind die Geschäftsführer von BROOKHAIL LAND LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROSENBERG, David
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    Sekretär
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    British2541410004
    ANGUS, George David
    30 Cause End Road
    MK43 9DB Wootton
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    30 Cause End Road
    MK43 9DB Wootton
    Bedfordshire
    EnglandBritish6279030001
    CONWAY, Stephen Stuart Solomon
    Penthouse 5
    Harley House Regents Park
    NW1 5HN London
    Geschäftsführer
    Penthouse 5
    Harley House Regents Park
    NW1 5HN London
    United Arab EmiratesBritish197472860001
    LANDESBERG, Gary Mitchell
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    Geschäftsführer
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    United KingdomBritish54137480002
    ROSENBERG, David
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritish2541410004
    ROSENBERG, Elliot Simon
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish2541420006
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    LANDESBERG, Alan
    154 Barnet Road
    EN5 3LJ Barnet
    Lightstone House
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    154 Barnet Road
    EN5 3LJ Barnet
    Lightstone House
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish142883260002
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Hat BROOKHAIL LAND LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 29. März 2007
    Geliefert am 31. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Irish Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 31. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. März 2007
    Geliefert am 10. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Royal pavilion 2 pier road north woolwich london, 4 and 6 pier road north woolwich aforesaid and the new gog public house 43 masons road london together with all fixtures and fittings and chattels personal whatsoever also with the goodwill of any trades or business and first fixed charge on all money received or to be received by or on behalf of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Irish Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 24. März 2003
    Geliefert am 25. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the oast house P.H. petts hill in the l/b of ealing t/nos: AGL37635 AGL37652 and AGL113365. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Simonow Trading Limited and Finance and Credit Corporation Limited
    Transaktionen
    • 25. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 06. März 2003
    Geliefert am 07. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as the mill,woolpack lane,nottingham; t/no NT106919; f/hold known as 29 woolpack lane,nottingham; NT123145 and f/hold land on the west of belward st,nottingham; NT113448; all fixtures fittings fixed plant and machinery thereon.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 05. März 2003
    Geliefert am 07. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Elm Property Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 05. März 2003
    Geliefert am 07. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the oast house P.H. petts hill t/nos: AGL37635 AGL37652 and AGL113365. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Elm Property Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 2003
    Geliefert am 11. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the new gog public house 38 freemasons road west ham london t/n egl 295595 including all fixtures fittings fixed plant and machinery thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 06. Feb. 2003
    Geliefert am 11. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 09. Jan. 2003
    Geliefert am 16. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of floating charge its undertaking and all property and other assets.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Jan. 2003
    Geliefert am 16. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a keston mark 65 croydon road keston bromley BR2 6EH t/no SGL628733 inc all fixtures fittings fixed plant and machinery thereon.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Dez. 2002
    Geliefert am 12. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a the mill woolpack lane hockley nottingham t/n NT106919 NT123145 and NT113448 and by way of floating charge all moveable plane machinery implements furniture and equipment at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Simonow Trading Limited and Finance and Credit Corporation Limited
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Dez. 2002
    Geliefert am 07. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property the belvedere tavern 43 linden grove camberwell in the london borough of southwark t/n 310935. by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture and equipment at the property.
    Berechtigte Personen
    • Simonow Trading Limited and Finance and Credit Corporation Limited
    Transaktionen
    • 07. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Nov. 2002
    Geliefert am 11. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as cremorne hotel queens walk nottingham NG2 1JT t/n NT349885.
    Berechtigte Personen
    • Principality Building Society
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Nov. 2002
    Geliefert am 11. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as the duke of newcastle basford nottingham t/n NT249852.
    Berechtigte Personen
    • Principality Building Society
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Okt. 2002
    Geliefert am 06. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a the new gog public house freemasons road in the london borough of newham t/n EGL295595 and by way of. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Simonow Trading Limited and Finance and Credit Corporation Limited
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Aug. 2002
    Geliefert am 13. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property situate and known as the ennismore arms public house in the london borough of westminster t/n 310958.
    Berechtigte Personen
    • Elm Property Finance Limited
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juli 2002
    Geliefert am 01. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H the white hart hotel P.h church road willesden in the l/b of brent t/n NGL47739.
    Berechtigte Personen
    • Grove Property Finance Limited
    Transaktionen
    • 01. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Juni 2002
    Geliefert am 13. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Dukes tavern cambridge rd,norbiton,london borough of kingston upon thames; the goodwill of business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Apr. 2002
    Geliefert am 26. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the royal pavilion hotel, 2 pier road, north woolwich, l/b of newham t/nos. 252550 and LN249728. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Finance and Credit Corporation Limited and Tores B.V.
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Apr. 2002
    Geliefert am 26. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the royal pavilion hotel, 2 pier road, north woolwich, l/b of newham t/nos. 252550 and LN249728. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Grove Property Finance Limited
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Second legal charge
    Erstellt am 08. Apr. 2002
    Geliefert am 11. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a the royal pavilion hotel 2 pier road north woolwich newham and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Finance & Credit Corporation Limited and Tores B.V
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Apr. 2002
    Geliefert am 11. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as the royal pavilion hotel 2 pier road north woolwich t/n 252550. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Grove Property Finance Limited
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Jan. 2002
    Geliefert am 23. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a unicorn P.H. 202 hoxton street, shoreditch in the london borough of hackney, t/no LN3650.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Finance & Credit Corporation Limited & Simonow Trading Limited
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Jan. 2002
    Geliefert am 23. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property situate at and k/a the dukes tavern (formerly the duke of cambridge P.H.) cambridge road, norbiton in the london borough of kingston upon thames t/no SGL66322.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Finance & Credit Corporation Limited & Simonow Trading Limited
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0