DUNEDIN (BRAINTREE) UK II LIMITED

DUNEDIN (BRAINTREE) UK II LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDUNEDIN (BRAINTREE) UK II LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04346454
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DUNEDIN (BRAINTREE) UK II LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich DUNEDIN (BRAINTREE) UK II LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O BDO STOY HAYWOOD LLP
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DUNEDIN (BRAINTREE) UK II LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PANELBRIGHT LIMITED03. Jan. 200203. Jan. 2002

    Welche sind die letzten Einreichungen für DUNEDIN (BRAINTREE) UK II LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Jan. 2010

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    legacy

    1 Seiten287

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 18. Juni 2009

    LRESSP

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    4 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    4 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    4 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    8 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    4 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2003

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2002

    4 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von DUNEDIN (BRAINTREE) UK II LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SCOTT, Keith
    Clarendon Road
    HP16 0PL Prestwood
    Michaelmas Farm
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Clarendon Road
    HP16 0PL Prestwood
    Michaelmas Farm
    Buckinghamshire
    British141163370001
    KASCH, Peter Carwile
    Filston Oast
    Filston Lane
    TN14 5JU Shoreham
    Kent
    Geschäftsführer
    Filston Oast
    Filston Lane
    TN14 5JU Shoreham
    Kent
    United KingdomBritish61386600003
    NEWISS, Julian Ralph Stewart
    Steanbridge House
    Slad
    GL6 7QE Stroud
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Steanbridge House
    Slad
    GL6 7QE Stroud
    Gloucestershire
    EnglandBritish25776880001
    WILSON, Guy Ian Swinburn
    Culham House
    High Street Culham
    OX14 4NA Abingdon
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Culham House
    High Street Culham
    OX14 4NA Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish141163410001
    FULLERTON, Albert Smyth
    37 Granby Road
    Newington
    EH16 5NP Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    37 Granby Road
    Newington
    EH16 5NP Edinburgh
    Midlothian
    British76362700001
    LANGRIDGE, Megan Joy
    10 Kingshill Drive
    Hoo
    ME3 9JP Rochester
    Kent
    Sekretär
    10 Kingshill Drive
    Hoo
    ME3 9JP Rochester
    Kent
    British86459820001
    TRIBE, Nicholas John Grove
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    Sekretär
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    British141163390001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARRY, Roun Brendan
    Saracens
    Saunders Lane
    GU22 0NU Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Saracens
    Saunders Lane
    GU22 0NU Woking
    Surrey
    EnglandIrish26177120002
    FULLERTON, Albert Smyth
    37 Granby Road
    Newington
    EH16 5NP Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    37 Granby Road
    Newington
    EH16 5NP Edinburgh
    Midlothian
    British76362700001
    GIBSON, Scott
    9 Harelaw Road
    EH13 0DR Edinburgh
    Geschäftsführer
    9 Harelaw Road
    EH13 0DR Edinburgh
    British48147540001
    HILL, Nicholas Mark Lalor
    36 Hazlewell Road
    SW15 6LR London
    Geschäftsführer
    36 Hazlewell Road
    SW15 6LR London
    United KingdomBritish76547250001
    KLIMT, Peter Richard
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    Geschäftsführer
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    United KingdomBritish23621230001
    LEE, Wilson Yao Chang
    28 Ellerdale Road
    Hampstead
    NW3 6BB London
    Geschäftsführer
    28 Ellerdale Road
    Hampstead
    NW3 6BB London
    American52557130001
    LOMAS, Ian Paul
    Caledon Road
    HP9 2BX Beaconsfield
    21
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Caledon Road
    HP9 2BX Beaconsfield
    21
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish94970360001
    NAGGAR, Guy Anthony
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    Geschäftsführer
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    United KingdomItalian1496660001
    PETTIT, Andrew John
    37 Aberdeen Road
    N5 2YG London
    Geschäftsführer
    37 Aberdeen Road
    N5 2YG London
    British62947400001
    ROGERS, Paul
    Ash Barton
    20 The Ridgeway
    WD7 8PR Radlett
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Ash Barton
    20 The Ridgeway
    WD7 8PR Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish41216370001
    SHEPPARD, Hamish
    St Peters House
    Chafford Lane Fordcombe
    TN3 0SH Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    St Peters House
    Chafford Lane Fordcombe
    TN3 0SH Tunbridge Wells
    Kent
    British87314760001
    SOLLEY, Ian Peter
    St Peter`S House
    Chafford Lane, Fordcombe
    TN3 0SH Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    St Peter`S House
    Chafford Lane, Fordcombe
    TN3 0SH Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish142265990001
    TRIBE, Nicholas John Grove
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritish141163390001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat DUNEDIN (BRAINTREE) UK II LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 01. Juli 2003
    Geliefert am 04. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finanace parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juni 2003
    Geliefert am 04. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land being george yard shopping centre, braintree t/no. EX668815 and l/h land being land on the west side of 23 bank street, braintree t/no. EX648050. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland ("the Security Trustee")
    Transaktionen
    • 04. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 29. Juli 2002
    Geliefert am 07. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including (I) l/hold property known as the arndale centre,stretford,manchester and 22-40 kings st,stretford,manchester; t/nos GM654979 and GM654978; (ii) f/hold property known as the george yard shopping centre,braintree,essex; EX648050 and EX668815; (iii) f/hold property lying to the east side of bristol rd,south birmingham and the leasehold property being shop unit 48,grosvenor centre,northfield; WM52089 and WM364294; (iv) the liscard shopping centre (also known as cherrytree centre) wallasey,merseyside; MS305060. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft,London Branch
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 22. Dez. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Juli 2002
    Geliefert am 07. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and branchspin limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Freehold and leasehold land known as george yard,braintree; f/hold t/no EX668815; l/hold t/no EX648050. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Juli 2002
    Geliefert am 07. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Juni 2002
    Geliefert am 17. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the property k/a the george yard shopping centre, braintree, essex t/n EX648050 and EX668815. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mable Commercial Funding Limited (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 17. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Juni 2002
    Geliefert am 14. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all their estates or interests in the legally mortgaged property that being george yard shopping centre, braintree, essex t/n EX648050 and EX66815. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 14. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat DUNEDIN (BRAINTREE) UK II LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    25. Apr. 2010Aufgelöst am
    18. Juni 2009Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0