CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04349711 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Castlegarth Grange, Scott Lane Wetherby LS22 6LH West Yorkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
BROOMCO (2778) LIMITED | 09. Jan. 2002 | 09. Jan. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Aug. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Jan. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Jan. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2022 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Jan. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2021 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Jan. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2020 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2019 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2018 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Jan. 2019 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2017 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2016 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2015 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Caddick am 01. Jan. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2014 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Andrew Bullers als Sekretär am 01. März 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Andrew Bullers als Direktor am 01. März 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULLERS, Paul Andrew | Sekretär | Castlegarth Grange, Scott Lane Wetherby LS22 6LH West Yorkshire | 195601260001 | |||||||
BULLERS, Paul Andrew | Geschäftsführer | Castlegarth Grange, Scott Lane Wetherby LS22 6LH West Yorkshire | United Kingdom | British | Finance Director | 155801480001 | ||||
CADDICK, Paul | Geschäftsführer | Castlegarth Grange, Scott Lane Wetherby LS22 6LH West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 2288420001 | ||||
HULME, Alexandra Victoria | Geschäftsführer | Castlegarth Grange, Scott Lane Wetherby LS22 6LH West Yorkshire | England | British | Retail Director | 68707520004 | ||||
BARKER, Stephen Edmund | Sekretär | 28 Cockey Moor Road Starling BL8 2HB Bury Lancashire | British | Chartered Accountant | 36888510001 | |||||
HIRST, Peter Graham | Sekretär | The Coach House Outwood Lane Horsforth LS18 4HR Leeds West Yorkshire | British | Chartered Accountant | 32603370002 | |||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
BARKER, Stephen Edmund | Geschäftsführer | 28 Cockey Moor Road Starling BL8 2HB Bury Lancashire | British | Company Director | 36888510001 | |||||
HIRST, Peter Graham | Geschäftsführer | The Coach House Outwood Lane Horsforth LS18 4HR Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 32603370002 | ||||
HOPE, Margaret Mary | Geschäftsführer | 12 Alstone Road Heaton Chapel SK4 5AH Stockport | British | Consultant | 69369810001 | |||||
WEATHERHEAD, Richard | Geschäftsführer | Aketon Close Haggs Road Follifoot HG3 1AZ Harrogate | England | British | Chartered Accountant | 37336810004 | ||||
DLA NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caddick Developments Limited | 06. Apr. 2016 | Scott Lane LS22 6LH Wetherby Castlegarth Grange England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 24. Feb. 2006 Geliefert am 09. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Property k/a land and buildings on the east and west side of broad street kings lynn and 2-46 (even) new conduit street kings lynn part t/n NK234700. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge security over shares | Erstellt am 12. Nov. 2003 Geliefert am 24. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All securities and their proceeds of sale all dividends interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 12. Nov. 2003 Geliefert am 24. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold property k/a land and buildings on the east and west side of broad street kings lynn and 2-44 (even) new conduit street kings lynn, the ground floor of the coffee house and 46 new conduit street kings lynn norfolk t/n NK234700 and NK180780. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 12. Nov. 2003 Geliefert am 24. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge and assignment by way of security | Erstellt am 12. Nov. 2003 Geliefert am 25. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Right title and interest, present and future in respect of the agreements. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 25. Apr. 2002 Geliefert am 15. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the hedging counterparty under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed (creating a charge and assignment) | Erstellt am 25. Apr. 2002 Geliefert am 15. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from es (vancouver centre) nominee no.1 Limited and es (vancouver centre) nominee no.2 Limited (the nominees) or the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The land and buildings on the east and west side of broad street kings lynn under the lease (as defined therein) 2-44 (even) new conduit street kings lynn under the lease (as defined therein) and 46 new conduit street kings lynn under the lease (as defined therein) together k/a the vancouver centre kings lynn norfolk and the car park on the east side of broad street kings lynn t/n NK234700, NK180780. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over cash deposit | Erstellt am 25. Apr. 2002 Geliefert am 15. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the deposit and the debt (as defined therein). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 25. Apr. 2002 Geliefert am 15. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or to the hedging counterparty under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed (creating a charge and assignment) | Erstellt am 25. Apr. 2002 Geliefert am 15. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from es (vancouver centre) nominee no.1 Limited and es (vancouver centre) nominee no.2 Limited (the nominees) or the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The land and buildings on the east and west side of broad street kings lynn under the lease (as defined therein) 2-44 (even) new conduit street kings lynn under the lease (as defined therein) and 46 new conduit street kings lynn under the lease (as defined therein) together k/a the vancouver centre kings lynn norfolk and the car park on the east side of broad street kings lynn t/n NK234700, NK180780. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 25. Apr. 2002 Geliefert am 07. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The leasehold property k/a land and buildings on then east and west side of broad street kings lynn t/n NK234700 and the leasehold property k/a 2-46 new conduit street kings lynn t/n NK180780 together with such right title and interest as the seller has in the two storey car park situated on the east side of broad street kings lynn to be demised pursuant to the car park agreement. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deposit deed | Erstellt am 25. Apr. 2002 Geliefert am 07. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The deposit and all its interest in the account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 25. Apr. 2002 Geliefert am 03. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land and buildings on the east and west side of broad street kings lynn with title absolute under t/n NK234700 (for further to details of property charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Equitable charge over beneficial interests | Erstellt am 25. Apr. 2002 Geliefert am 03. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the nominees or the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All that l/h land k/a land and buildings on the east and west side of broad street kings lynn with title absolute under title number NK234700 and 2-44 (even) new conduit street king's lynn title absolute under title number NK180780 together k/a the vancouver centre king's lynn norfolk. And such right title and interest in the 2 storey car park on the east side of broad street king's lynn pursuant to an agreement for works and underlease dated 15 april 1983. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 28. März 2002 Geliefert am 05. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £952,425.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The leasehold property known as land and buildings on the east and west side of broad street kings lynn t/n NK234700 and the leasehold property known as 2-46 conduit street kings lynn t/n NK180780. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0