CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED

CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCADDICK (KING'S LYNN) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04349711
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Castlegarth Grange, Scott Lane
    Wetherby
    LS22 6LH West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BROOMCO (2778) LIMITED09. Jan. 200209. Jan. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2022

    Welche sind die letzten Einreichungen für CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Jan. 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Jan. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2022

    1 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Jan. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2021

    1 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Jan. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2020

    1 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2019

    15 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2018

    16 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Jan. 2019 mit Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2017

    17 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2016

    16 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2015

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 12. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 350,002
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Caddick am 01. Jan. 2016

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2014

    13 SeitenAA

    Ernennung von Mr Paul Andrew Bullers als Sekretär am 01. März 2015

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Paul Andrew Bullers als Direktor am 01. März 2015

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BULLERS, Paul Andrew
    Castlegarth Grange, Scott Lane
    Wetherby
    LS22 6LH West Yorkshire
    Sekretär
    Castlegarth Grange, Scott Lane
    Wetherby
    LS22 6LH West Yorkshire
    195601260001
    BULLERS, Paul Andrew
    Castlegarth Grange, Scott Lane
    Wetherby
    LS22 6LH West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Castlegarth Grange, Scott Lane
    Wetherby
    LS22 6LH West Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director155801480001
    CADDICK, Paul
    Castlegarth Grange, Scott Lane
    Wetherby
    LS22 6LH West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Castlegarth Grange, Scott Lane
    Wetherby
    LS22 6LH West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director2288420001
    HULME, Alexandra Victoria
    Castlegarth Grange, Scott Lane
    Wetherby
    LS22 6LH West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Castlegarth Grange, Scott Lane
    Wetherby
    LS22 6LH West Yorkshire
    EnglandBritishRetail Director68707520004
    BARKER, Stephen Edmund
    28 Cockey Moor Road
    Starling
    BL8 2HB Bury
    Lancashire
    Sekretär
    28 Cockey Moor Road
    Starling
    BL8 2HB Bury
    Lancashire
    BritishChartered Accountant36888510001
    HIRST, Peter Graham
    The Coach House
    Outwood Lane Horsforth
    LS18 4HR Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    The Coach House
    Outwood Lane Horsforth
    LS18 4HR Leeds
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant32603370002
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Sekretär
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    BARKER, Stephen Edmund
    28 Cockey Moor Road
    Starling
    BL8 2HB Bury
    Lancashire
    Geschäftsführer
    28 Cockey Moor Road
    Starling
    BL8 2HB Bury
    Lancashire
    BritishCompany Director36888510001
    HIRST, Peter Graham
    The Coach House
    Outwood Lane Horsforth
    LS18 4HR Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Coach House
    Outwood Lane Horsforth
    LS18 4HR Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant32603370002
    HOPE, Margaret Mary
    12 Alstone Road
    Heaton Chapel
    SK4 5AH Stockport
    Geschäftsführer
    12 Alstone Road
    Heaton Chapel
    SK4 5AH Stockport
    BritishConsultant69369810001
    WEATHERHEAD, Richard
    Aketon Close
    Haggs Road Follifoot
    HG3 1AZ Harrogate
    Geschäftsführer
    Aketon Close
    Haggs Road Follifoot
    HG3 1AZ Harrogate
    EnglandBritishChartered Accountant37336810004
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Caddick Developments Limited
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    06. Apr. 2016
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    Nein
    RechtsformUk Private Limited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland & Wales
    Registrierungsnummer02460630
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat CADDICK (KING'S LYNN) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 24. Feb. 2006
    Geliefert am 09. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a land and buildings on the east and west side of broad street kings lynn and 2-46 (even) new conduit street kings lynn part t/n NK234700. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge security over shares
    Erstellt am 12. Nov. 2003
    Geliefert am 24. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All securities and their proceeds of sale all dividends interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Nov. 2003
    Geliefert am 24. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold property k/a land and buildings on the east and west side of broad street kings lynn and 2-44 (even) new conduit street kings lynn, the ground floor of the coffee house and 46 new conduit street kings lynn norfolk t/n NK234700 and NK180780. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Nov. 2003
    Geliefert am 24. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge and assignment by way of security
    Erstellt am 12. Nov. 2003
    Geliefert am 25. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right title and interest, present and future in respect of the agreements.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Apr. 2002
    Geliefert am 15. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the hedging counterparty under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alfred Mcalpine Construction Limited
    Transaktionen
    • 15. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed (creating a charge and assignment)
    Erstellt am 25. Apr. 2002
    Geliefert am 15. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from es (vancouver centre) nominee no.1 Limited and es (vancouver centre) nominee no.2 Limited (the nominees) or the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The land and buildings on the east and west side of broad street kings lynn under the lease (as defined therein) 2-44 (even) new conduit street kings lynn under the lease (as defined therein) and 46 new conduit street kings lynn under the lease (as defined therein) together k/a the vancouver centre kings lynn norfolk and the car park on the east side of broad street kings lynn t/n NK234700, NK180780. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Laing O'rourke Special Projects Limited
    Transaktionen
    • 15. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 25. Apr. 2002
    Geliefert am 15. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the deposit and the debt (as defined therein).
    Berechtigte Personen
    • Alfred Mcalpine Construction Limited
    Transaktionen
    • 15. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Apr. 2002
    Geliefert am 15. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or to the hedging counterparty under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Laing O'rourke Special Projects Limited
    Transaktionen
    • 15. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed (creating a charge and assignment)
    Erstellt am 25. Apr. 2002
    Geliefert am 15. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from es (vancouver centre) nominee no.1 Limited and es (vancouver centre) nominee no.2 Limited (the nominees) or the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The land and buildings on the east and west side of broad street kings lynn under the lease (as defined therein) 2-44 (even) new conduit street kings lynn under the lease (as defined therein) and 46 new conduit street kings lynn under the lease (as defined therein) together k/a the vancouver centre kings lynn norfolk and the car park on the east side of broad street kings lynn t/n NK234700, NK180780. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alfred Mcalpine Construction Limited (The Lender)
    Transaktionen
    • 15. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Apr. 2002
    Geliefert am 07. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The leasehold property k/a land and buildings on then east and west side of broad street kings lynn t/n NK234700 and the leasehold property k/a 2-46 new conduit street kings lynn t/n NK180780 together with such right title and interest as the seller has in the two storey car park situated on the east side of broad street kings lynn to be demised pursuant to the car park agreement. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eagle Star Life Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 07. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deposit deed
    Erstellt am 25. Apr. 2002
    Geliefert am 07. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The deposit and all its interest in the account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eagle Star Life Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 07. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Apr. 2002
    Geliefert am 03. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the east and west side of broad street kings lynn with title absolute under t/n NK234700 (for further to details of property charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kbc Bank Nv
    Transaktionen
    • 03. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Equitable charge over beneficial interests
    Erstellt am 25. Apr. 2002
    Geliefert am 03. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the nominees or the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that l/h land k/a land and buildings on the east and west side of broad street kings lynn with title absolute under title number NK234700 and 2-44 (even) new conduit street king's lynn title absolute under title number NK180780 together k/a the vancouver centre king's lynn norfolk. And such right title and interest in the 2 storey car park on the east side of broad street king's lynn pursuant to an agreement for works and underlease dated 15 april 1983. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kbc Bank Nv
    Transaktionen
    • 03. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. März 2002
    Geliefert am 05. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £952,425.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The leasehold property known as land and buildings on the east and west side of broad street kings lynn t/n NK234700 and the leasehold property known as 2-46 conduit street kings lynn t/n NK180780. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alfred Mcalpine Construction Limited
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0