HIVELAND PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHIVELAND PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04351461
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HIVELAND PROPERTIES LIMITED?

    • (7031) /

    Wo befindet sich HIVELAND PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Pearl Assurance House 319 Ballards Lane
    North Finchley
    N12 8LY London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HIVELAND PROPERTIES LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2003
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Okt. 2004
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2002

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für HIVELAND PROPERTIES LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis11. Jan. 2017
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung25. Jan. 2017
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für HIVELAND PROPERTIES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für HIVELAND PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 03. März 2014

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 02. Sept. 2013

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 03. März 2014

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 02. Sept. 2013

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. März 2013

    2 Seiten3.6

    legacy

    1 SeitenLQ02

    legacy

    3 SeitenLQ01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 25. Juni 2011

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 25. Juni 2010

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 25. Dez. 2010

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 25. Dez. 2009

    2 Seiten3.6

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    600

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    4 SeitenAC92

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 03. Dez. 2009

    2 Seiten3.6

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    4 Seiten4.72

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    4 Seiten405(1)

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    5 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von HIVELAND PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    REILLY, Julian Hugh George
    Oak Tree House
    3 Gravel Hill
    UB8 1PB Uxbridge
    Sekretär
    Oak Tree House
    3 Gravel Hill
    UB8 1PB Uxbridge
    British10384040002
    COHEN, Matisyahu Nachum
    20 Hazedef Street
    66107 Tel Aviv Jaffa
    66107
    Israel
    Geschäftsführer
    20 Hazedef Street
    66107 Tel Aviv Jaffa
    66107
    Israel
    AmericanCompany Director120990560001
    GROSSFELD, Gal
    24/1 Beit Haeshell Street
    68025 Tel Aviv Jaffa
    68025
    Israel
    Geschäftsführer
    24/1 Beit Haeshell Street
    68025 Tel Aviv Jaffa
    68025
    Israel
    IsraeliAccountant120582660001
    BRAZIER, Andrea
    12 Ridge Road
    SM3 9LJ Sutton
    Surrey
    Sekretär
    12 Ridge Road
    SM3 9LJ Sutton
    Surrey
    BritishCompany Secretary37894420001
    GROSSFELD, Gal
    24/1 Beit Haeshell Street
    68025 Tel Aviv Jaffa
    68025
    Israel
    Sekretär
    24/1 Beit Haeshell Street
    68025 Tel Aviv Jaffa
    68025
    Israel
    Israeli120582660001
    SDG SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900023560001
    SLC CORPORATE SERVICES LIMITED
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    Sekretär
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    74654310001
    WALGATE SERVICES LIMITED
    25 North Row
    W1K 6DJ London
    Sekretär
    25 North Row
    W1K 6DJ London
    59142480001
    COHEN, Matisyahu Nachum
    20 Hazedef Street
    66107 Tel Aviv Jaffa
    66107
    Israel
    Geschäftsführer
    20 Hazedef Street
    66107 Tel Aviv Jaffa
    66107
    Israel
    AmericanCompany Director120990560001
    COWAN, Paterson
    Flat 8 Limes Court
    23 Brondesbury Park
    NW6 7BS London
    Geschäftsführer
    Flat 8 Limes Court
    23 Brondesbury Park
    NW6 7BS London
    BritishProperty Consultant80150120002
    IVES, Stephen Edward
    Cottars
    St Leonards Hill
    SL4 4AL Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Cottars
    St Leonards Hill
    SL4 4AL Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant50173270002
    MAIMON, Jehuda
    Taberkin 16
    Tel Aviv
    69357
    Geschäftsführer
    Taberkin 16
    Tel Aviv
    69357
    IsraeliTax Advisor100974630001
    YOSHPE, Gideon
    33 Brim Hill
    N2 0HD London
    Geschäftsführer
    33 Brim Hill
    N2 0HD London
    IsraeliCompany Director73657620001
    SDG REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900023550001

    Hat HIVELAND PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Third party legal charge
    Erstellt am 06. Okt. 2005
    Geliefert am 11. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a land and buildings on the north-east side of walton road, felixstowe, suffolk, t/no SK201120, by way of assignment the rental income, the benefit of all agreements, by way of floating charge all moveable plant, machinery implements, utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Israel Discount Bank Limited
    Transaktionen
    • 11. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juli 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 320. März 2012Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 130. Mai 2012Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
    • 324. Juni 2014Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 1
      • Aktenzeichen 3
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juni 2005
    Geliefert am 16. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £400,000 and all other monies due or to become dueunder the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H land and buildings on the north east side of walton avenue felixstowe suffolk t/no SK201120.
    Berechtigte Personen
    • English and Continental Properties Limited
    Transaktionen
    • 16. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Second legal charge
    Erstellt am 13. Mai 2004
    Geliefert am 21. Mai 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from dock lane properties limited and/or snowgram limited and/or their subsidiaries or related parties to the chargee (lender) and all sums deposited by the lender with 0BANK of scotland and with israel discount bank to secure facilities which are or will be advanced to the dock lane group and or its subsidiaries or related parties
    Kurze Angaben
    3/4 cambridge road milton cambridge 323 leeds road huddersfield west yorkshire t/no. WYK320735 land and buildings at hodson street wigan lancashire underleasehold interest in land at walton avenue felixstowe suffolk.
    Berechtigte Personen
    • Dorot Properties and Holdings Limited and Dorot Malta Limited
    Transaktionen
    • 21. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 03. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 22 gower road hayward heath west sussex title number SX16327. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 03. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The leasehold property known as walton avenue felixstowe suffolk title number SK201120. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 03. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 45 regent street plymouth devon title number DN118886. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 03. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as freehold land and buildings on the south east side of hodson street wigan lancashire title number GM841923. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 03. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as land on the north east side of forty acre road boongate peterborough cambridgeshire title number CB237156. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 03. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 03. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The leasehold property known as 323 leeds road huddersfield west yorkshire title number WYK320735. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 03. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 3-4 cambridge road chesterton cambridgeshire title number CB221445. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 03. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 12, the parade oxford garden city estate kidlington oxfordshire title number ON211118. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 03. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 4 & 6 denmark street bletchley buckinghamshire title number BM251946. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 03. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The leasehold property known as 12 & 13 block c britannia business park aylesford maidstone kent title number K650106. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 25. Juli 2002
    Geliefert am 26. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge over all the company's present and future undertakings and assets whatever and wherever.
    Berechtigte Personen
    • Woolwich PLC
    Transaktionen
    • 26. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 24. Juli 2002
    Geliefert am 26. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    45 regent street plymouth t/n DN118886, 3 and 4 cambridge road chesterton t/n CB221445, 12 the parade oxford garden city estate kidlington t/n ON211118 (for full details of further properties charged plese refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Woolwich PLC
    Transaktionen
    • 26. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat HIVELAND PROPERTIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stuart Anthony Jones
    Brunswick House
    Brunswick Place
    Southampton
    So15 2ap
    Receiver Manager
    Brunswick House
    Brunswick Place
    Southampton
    So15 2ap
    Stuart Lennox Foreman
    Savills (Uk) Limited Trinity Court
    Trinity Street
    PE1 1DA Peterborough
    Receiver Manager
    Savills (Uk) Limited Trinity Court
    Trinity Street
    PE1 1DA Peterborough
    2
    DatumTyp
    14. Nov. 2008Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London
    Praktiker
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London
    3Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Nigel Patrick London
    Chart Property Receivership And Recoveries Chart House
    88 Bushey Way
    BR3 6TD Beckenham
    Kent
    United Kingdom
    Receiver Manager
    Chart Property Receivership And Recoveries Chart House
    88 Bushey Way
    BR3 6TD Beckenham
    Kent
    United Kingdom
    Derek Peter Mason
    Chart Property Receivership And Recoveries Chart House
    88 Bushey Way
    BR3 6TD Beckenham
    Kent
    Receiver Manager
    Chart Property Receivership And Recoveries Chart House
    88 Bushey Way
    BR3 6TD Beckenham
    Kent

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0