EPISTROPHE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EPISTROPHE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04358049 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EPISTROPHE LIMITED?
- Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Aktivitäten (63110) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich EPISTROPHE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EPISTROPHE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| VELOCIX LIMITED | 01. Dez. 2008 | 01. Dez. 2008 |
| CACHELOGIC LIMITED | 01. Aug. 2005 | 01. Aug. 2005 |
| SAVISO GROUP LIMITED | 22. Jan. 2002 | 22. Jan. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EPISTROPHE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EPISTROPHE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 12 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Apr. 2021 | 9 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Cormac Vincent Whelan als Geschäftsführer am 31. Dez. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 More London Place London SE1 2AF zum 1 More London Place London SE1 2AF am 18. Juni 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 740 Waterside Drive Aztec West Almondsbury Bristol United Kingdom BS32 4UF zum 740 Waterside Drive Aztec West Almondsbury Bristol BS32 4UF geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 740 Waterside Drive Aztec West Almondsbury Bristol United Kingdom BS32 4UF verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 740 Waterside Drive Aztec West Almondsbury Bristol United Kingdom BS32 4UF verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 740 Waterside Drive Aztec West Almondsbury Bristol BS32 4UF England zum 1 More London Place London SE1 2AF am 28. Mai 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 740 Waterside Drive Aztec West Almondsbury Bristol United Kingdom BS32 4UF geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 7 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 06. Apr. 2020
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung von Mr Scott Ashley Wallberg als Direktor am 05. Feb. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ioli Tassopoulou als Geschäftsführer am 05. Feb. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2018 bis 30. Juni 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Cormac Vincent Whelan als Direktor am 23. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Trevor Dryden Foster als Direktor am 23. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen John Vogelsang als Geschäftsführer am 23. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EPISTROPHE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOSTER, Trevor Dryden | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | England | British | 219680750001 | |||||
| WALLBERG, Scott Ashley | Geschäftsführer | 3 Sheldon Square W2 6PY London Nokia England | England | British | 266584090001 | |||||
| AMESBURY, Bryan Mark | Sekretär | 54 Alexander Chase CB6 3SW Ely Cambridgeshire | British | 67063580006 | ||||||
| HODGES, Debbie Carol | Sekretär | Ely Road Milton CB24 6DD Cambridge 3 United Kingdom | British | 147575070001 | ||||||
| LEE, John | Sekretär | 36 Maids Causeway CB5 8DD Cambridge | British | 1975520002 | ||||||
| NICOLL, Amanda Jane | Sekretär | Waterside Drive Aztec West BS32 4TR Bristol 740 United Kingdom | 180118940001 | |||||||
| ADRIANS INTERNATIONAL CONSULTANTS LIMITED | Sekretär | 4 Boys British School East Street CB10 1LH Saffron Walden Essex | 41272030001 | |||||||
| AHMED, Tahir | Geschäftsführer | Blackberry Way Pont Prennau CF23 8FE Cardiff 41 South Glamorgan | Wales | British | 103290510002 | |||||
| AMESBURY, Bryan Mark | Geschäftsführer | 54 Alexander Chase CB6 3SW Ely Cambridgeshire | United Kingdom | British | 67063580006 | |||||
| CHAPMAN-PINCHER, Patricia | Geschäftsführer | Flat 7 13-17 Long Lane EC1A 9PN London | United Kingdom | British | 51618810005 | |||||
| CORNWELL, Simon Anthony Vivian | Geschäftsführer | 11 Eton Road NW3 4SS London | England | British | 42636180001 | |||||
| CUMMINGS, Andrew Peter | Geschäftsführer | Ely Road Milton CB24 6DD Cambridge 3 Cambridgeshire England | England | British | 190614100001 | |||||
| DODD, Stewart Michael | Geschäftsführer | Flat 2 1 West Street WC2 London | British | 54693380002 | ||||||
| FELISIAK, Nicholas Christopher | Geschäftsführer | Le Varclin Rue Le Varclin St Martin GY4 6AW Guernsey | British | 96872740001 | ||||||
| FINLAY, Geoffrey John | Geschäftsführer | Magna Marbella 142 Nugva Andalucia Marbella 29600 Spain | British | 109242480001 | ||||||
| GALES, Benjamin John Francis | Geschäftsführer | 121 Cambridge Science Park Milton Road CB4 0FZ Cambridge Cambridgeshire | British | 104596730001 | ||||||
| GARRETT, Laurence Roy | Geschäftsführer | 30 Middle Street SG8 7RD Thriplow Cambridgeshire | England | British | 84914060002 | |||||
| GRAY, Stephen Douglas | Geschäftsführer | 304 Splitrock Road 03753 Grantham New Hampshire 03753 Usa | Usa | 81459500001 | ||||||
| GREIG, Alasdair Douglas Michael | Geschäftsführer | The Thatched Cottage Church Road, Chrishall SG8 8QT Royston Hertfordshire | British | 91354490001 | ||||||
| HERRIOT, Walter John | Geschäftsführer | 9 Shepreth Road Foxton CB2 6SU Cambridge Cambridgeshire | England | British | 13213440001 | |||||
| HILL, Stephen James | Geschäftsführer | Monks Well House Monks Well GU10 1RH Farnham Surrey | British | 68448760002 | ||||||
| ILLSLEY, Anthony Kim | Geschäftsführer | 4 St Peters Road TW1 1QX Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | 43836970001 | |||||
| LARBEY, Paul Douglas | Geschäftsführer | Ely Road Milton CB24 6DD Cambridge 3 United Kingdom | United Kingdom | British | 267456560002 | |||||
| LEE, John | Geschäftsführer | 36 Maids Causeway CB5 8DD Cambridge | England | British | 1975520002 | |||||
| MCDONAGH, Rodney Lawrence | Geschäftsführer | Ely Road Milton CB24 6DD Cambridge 3 United Kingdom | United Kingdom | British | 157998600001 | |||||
| MCKINNON, Alexander Wilson, Dr | Geschäftsführer | 42 Redford Road EH13 0AE Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 105591010001 | |||||
| NICOLL, Amanda Jane | Geschäftsführer | Stonehill Green Westlea SN5 7DJ Swindon The Quadrant Wiltshire England | England | British | 149770940001 | |||||
| PARKER, Andrew James | Geschäftsführer | 81 Parlour Close Histon CB4 9XR Cambridge Cambridgeshire | British | 80774620003 | ||||||
| ROBINSON, Phillip David | Geschäftsführer | Park House Queens Drive, Oxshott KT22 0PF Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | 119843810001 | |||||
| SADIQ, Liaqat Ali | Geschäftsführer | 22 Shortwood Avenue TW18 4JL Staines Middlesex | United Kingdom | British | 68493890001 | |||||
| TASSOPOULOU, Ioli | Geschäftsführer | 3 Sheldon Square W2 6PY London Nokia England | England | Greek | 248719360001 | |||||
| TWISS, Adam Dominic | Geschäftsführer | 17 Citygate Woodhead Drive CB4 1YL Cambridge Cambridgeshire | United Kingdom | British | 44597490005 | |||||
| VOGELSANG, Stephen John | Geschäftsführer | 1190 Beechwood Blvd Pittsburgh Pa 15206 United States | United States | American | 76903280001 | |||||
| WHELAN, Cormac Vincent | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | Irish | 185706160001 | |||||
| PAB NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | 4 Boys British School East Street CB10 1LH Saffron Walden Essex | 65281790001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EPISTROPHE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Oyj | 03. Okt. 2017 | Karaportti 3 PO BOX 22 Espoo Nokia 02610 Finland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Nokia Uk Limited | 06. Apr. 2016 | Waterside Drive, Aztec West Almondsbury BS32 4UF Bristol 740 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat EPISTROPHE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Extension letter | Erstellt am 01. Juli 2009 Geliefert am 14. Juli 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Extension letter | Erstellt am 01. Juli 2009 Geliefert am 04. Juli 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the investors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Nov. 2008 Geliefert am 13. Dez. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Nov. 2008 Geliefert am 02. Dez. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. März 2008 Geliefert am 20. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Juni 2007 Geliefert am 15. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 06. Juni 2006 Geliefert am 14. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The sum from time to time in a deposit account the sum of £10,827.63. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 25. Juli 2005 Geliefert am 27. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The initial sum of £57,777.69 in a deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 28. Juli 2004 Geliefert am 11. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat EPISTROPHE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0