MOWBRAY HOMES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MOWBRAY HOMES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04358124 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MOWBRAY HOMES LIMITED?
- Bau von Geschäftsgebäuden (41201) / Bauwesen
Wo befindet sich MOWBRAY HOMES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Harrier House 2 Lumsdale Road Cobra Business Park Trafford Park M32 0UT Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MOWBRAY HOMES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MOWBRAY HOMES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||
Change of details for Stewart Milne Group Limited as a person with significant control on 01. Aug. 2023 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2022 | 4 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Feb. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2021 | 4 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Feb. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2020 | 4 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Robert Fraser Pearson Park als Sekretär am 03. Sept. 2020 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Michael Sinclair Medine als Sekretär am 03. Sept. 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Mr Gerald Campbell More als Direktor am 26. Juni 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 4 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Robert Fraser Pearson Park als Direktor am 23. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Glenn Fraser Whyte Allison als Geschäftsführer am 31. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Feb. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 4 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Michael Sinclair Medine als Sekretär am 12. Juli 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Scott Craig Martin als Sekretär am 12. Juli 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 4 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Feb. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 4 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von MOWBRAY HOMES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARK, Robert Fraser Pearson | Sekretär | 2 Lumsdale Road Cobra Business Park Trafford Park M32 0UT Manchester Harrier House | 274119430001 | |||||||
| MACGREGOR, Stuart Alastair | Geschäftsführer | Westhill Business Park Westhill AB32 6JQ Aberdeen Peregrine House, Mosscroft Avenue Scotland | United Kingdom | British | 330152850001 | |||||
| MILNE, Stewart | Geschäftsführer | Baillieswells Road, Bieldside AB15 9BQ Aberdeen Dalhebity House United Kingdom | Scotland | British | 190960001 | |||||
| MORE, Gerald Campbell | Geschäftsführer | Westhill Business Park AB32 6JQ Aberdeen Peregrine House Scotland | Scotland | British | 211208700001 | |||||
| PARK, Robert Fraser Pearson | Geschäftsführer | 2 Lumsdale Road Cobra Business Park Trafford Park M32 0UT Manchester Harrier House | Scotland | British | 241939100001 | |||||
| ANDERSON, Lesley | Sekretär | 70 Woodend Crescent AB15 6YQ Aberdeen | British | 83529270002 | ||||||
| CORRAY, Pamela Jane | Sekretär | 146 Hamilton Place AB15 5BB Aberdeen Aberdeenshire | British | 83551930001 | ||||||
| MARTIN, Scott Craig | Sekretär | Mosscroft Avenue Westhill Business Park Westhill AB32 6JQ Aberdeen Peregrine House Scotland | 178780600001 | |||||||
| MCDONALD, Sandra | Sekretär | Tan Yr Allt LL65 3UG Bodedern Anglesey | British | 80266980001 | ||||||
| MEDINE, Michael Sinclair | Sekretär | 2 Lumsdale Road Cobra Business Park Trafford Park M32 0UT Manchester Harrier House | 248563610001 | |||||||
| OAG, Stuart Charles | Sekretär | Woodlands Crescent Cults AB15 9DH Aberdeen 7 Aberdeenshire | British | 129503880001 | ||||||
| BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite Lauren Court M33 2AF Wharf Road Sale Greater Manchester | 900018560001 | |||||||
| ALLISON, Glenn Fraser Whyte | Geschäftsführer | Linden Beeches 442 North Deeside Road AB15 9ET Cults Aberdeenshire | United Kingdom | British | 63687770002 | |||||
| IRVINE, John Christopher | Geschäftsführer | Forestside Road AB31 5ZH Banchory 38 Kincardineshire | Scotland | United Kingdom | 38442060003 | |||||
| MCDONALD, Sandra | Geschäftsführer | Tan Yr Allt LL65 3UG Bodedern Anglesey | British | 80266980001 | ||||||
| NUTTALL, Alan George | Geschäftsführer | 312a Leigh Road Worsley M28 1LH Manchester Lancashire | England | British | 20905600001 | |||||
| PATTISON, Phillip Richard | Geschäftsführer | 314 Leigh Road M28 4QU Worsley Manchester | British | 74233610001 | ||||||
| DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | The Britannia Suite Lauren Court M33 2AF Wharf Road Sale Greater Manchester | 900018550001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MOWBRAY HOMES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stewart Milne Group Limited | 06. Apr. 2016 | Westhill Business Park Westhill AB32 6JQ Aberdeen Peregrine House, Mosscroft Avenue United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MOWBRAY HOMES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 02. Apr. 2007 Geliefert am 18. Apr. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Aug. 2006 Geliefert am 16. Aug. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at chorlton fold farm monton eccles. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Juli 2005 Geliefert am 21. Juli 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land on the east side of worsley road north worsley t/n GM902075 and l/h land under t/n GM902074. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over a building contract | Erstellt am 26. Juni 2003 Geliefert am 04. Juli 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The rights under the building contract. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Mai 2003 Geliefert am 30. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property at holly bank orchard lane leigh t/no: GM817740. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Mai 2003 Geliefert am 30. Mai 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property at holly bank orchard lane leigh t/no: GM817740. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0