ELMSWAY (NO. 1) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameELMSWAY (NO. 1) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04359815
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?

    • (7012) /
    • (7020) /
    • (7032) /

    Wo befindet sich ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o CHANTREY VELLACOTT DFK LLP
    Russell Square House 10-12 Russell Square
    WC1B 5LF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BRITANNIC BUSINESS PARKS LIMITED10. Sept. 200210. Sept. 2002
    SOUTHTOUR LIMITED24. Jan. 200224. Jan. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Jan. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    23 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Mai 2012

    18 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Elmsway (No1) Limited Hercules Business Park Lostock Lane Lostock Bolton BL6 4BR England am 02. Juni 2011

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 09. Mai 2011

    LRESEX

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Canal Mill Botany Bay Villages Botany Brow Chorley Lancashire PR6 9AF am 22. Feb. 2011

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Jan. 2011

    Kapitalaufstellung am 26. Jan. 2011

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 23. Dez. 2010

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Jan. 2010 bis 30. Jan. 2010

    1 SeitenAA01

    Beendigung der Bestellung von Timothy Knowles als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Gerald Wood als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    legacy

    4 SeitenLQ01

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2009

    16 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2008

    16 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    2 SeitenAUD

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SHARP, Claire Caroline
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    Sekretär
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    British141979130001
    DIXON, William Ronald
    Cumberland Drive
    WA14 3QP Bowdon
    27
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Cumberland Drive
    WA14 3QP Bowdon
    27
    Cheshire
    EnglandBritish136501510001
    HOPKINSON, Thomas Duncan
    Bank House
    Sawley Road Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Bank House
    Sawley Road Sawley
    BB7 4RS Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritish71862660002
    SHARP, Claire Caroline
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish141979130001
    ALLEN, Rachel Mary
    1263 Burnley Road
    Loveclough
    BB4 8RG Rossendale
    Lancashire
    Sekretär
    1263 Burnley Road
    Loveclough
    BB4 8RG Rossendale
    Lancashire
    British98369110001
    JENKINSON, Jayne Elizabeth
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Sekretär
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    British85366800001
    SHARP, Claire Caroline
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    Sekretär
    The Croft
    Blackburn Road, Higher Wheelton
    PR6 8HL Chorley
    Lancashire
    British141979130001
    WESTHEAD, Paul
    11 Delph Way
    Whittle Le Woods
    PR6 7TG Chorley
    Lancashire
    Sekretär
    11 Delph Way
    Whittle Le Woods
    PR6 7TG Chorley
    Lancashire
    British72955010002
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    900018560001
    JENKINSON, Jayne Elizabeth
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Inglemere
    Langley Lane, Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    EnglandBritish85366800001
    KNOWLES, Timothy John Peter
    Clogh Willey Cottage
    Tosaby Road Stoney Mountain
    IM9 3AN St Marks
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    Clogh Willey Cottage
    Tosaby Road Stoney Mountain
    IM9 3AN St Marks
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish33274370003
    WESTHEAD, Paul
    11 Delph Way
    Whittle Le Woods
    PR6 7TG Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    11 Delph Way
    Whittle Le Woods
    PR6 7TG Chorley
    Lancashire
    British72955010002
    WOOD, Gerald Jospeh
    1 Stanley Road
    Farington
    PR25 4RH Leyland
    Lancashire
    Geschäftsführer
    1 Stanley Road
    Farington
    PR25 4RH Leyland
    Lancashire
    EnglandBritish110948700001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    900018550001

    Hat ELMSWAY (NO. 1) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security deed
    Erstellt am 12. Sept. 2006
    Geliefert am 25. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each borrower to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse, as Security Agent for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 128. Apr. 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 1
    Legal charge
    Erstellt am 09. Mai 2003
    Geliefert am 17. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Brownlow business park tennyson street bolton. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Mai 2003
    Geliefert am 17. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Florence business park whalley new road blackburn. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Mai 2003
    Geliefert am 17. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Waverledge business park waverledge street great harwood blackburn. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Dez. 2002
    Geliefert am 30. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second legal charge
    Erstellt am 09. Juli 2002
    Geliefert am 25. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The sum of £25,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Bronlow business park tennyson street bolton title number GM502273 waverledge mill waverledge street hyndburn title number LA36928 florence business park whaley new road blackburn title number LA386971 LA351831 LA351830 LA565627 LA374844 LA328794 together with all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery of the company from time to time thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Southern Funding Limited
    Transaktionen
    • 25. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Juli 2002
    Geliefert am 25. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Bronlow business park tennyson street bolton title number GM502273 waverledge mill waverledge street hyndburn title number LA36928 florence business park whaley new road blackburn title numbers LA386971 LA351831 LA351830 LA565627 LA374844 LA328794 together with all buildings trade and other fixtures fixed plant fixed plant and machinery of the company from time to time thereon.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Property Finance Nominees (No 4) Limited
    Transaktionen
    • 25. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Juli 2002
    Geliefert am 25. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Brownlow business park tennyson street bolton title number 502273, waverledge mill waverledge street hyndburn title number LA36928 florence business park whaley new road blackburn title numbers LA386971 LA351831 LA351830 LA565627 LA374844 LA328794. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Property Finance Nominees (No 4) Limited
    Transaktionen
    • 25. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 09. Juli 2002
    Geliefert am 23. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as waterledge mill,great harwood,hyndburn,lancashire; la 36928;specific charge over all income and rights thereto and the proceeds of sale thereof,lease or other disposition and all deeds and documents thereto; all insurance and compensation monies; floating charge over all undertaking,property,assets and rights whatsoever; see form 395 for details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 23. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 08. Juli 2002
    Geliefert am 23. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 23. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ELMSWAY (NO. 1) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Murphy
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Administrativer Receiver
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Bryn Williams
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Administrativer Receiver
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    2
    DatumTyp
    09. Mai 2011Beginn der Liquidation
    16. Okt. 2013Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Kevin Anthony Murphy
    Chantrey Vellacott Dfk
    Russell Square House
    WC1B 5LF 10-12 Russell Square
    London
    Praktiker
    Chantrey Vellacott Dfk
    Russell Square House
    WC1B 5LF 10-12 Russell Square
    London
    Richard Howard Toone
    Cvr Global Llp
    Russell Square House 10-12 Russell Square
    WC1B 5LB London
    Praktiker
    Cvr Global Llp
    Russell Square House 10-12 Russell Square
    WC1B 5LB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0