ELMSWAY (NO. 1) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ELMSWAY (NO. 1) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04359815 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?
- (7012) /
- (7020) /
- (7032) /
Wo befindet sich ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o CHANTREY VELLACOTT DFK LLP Russell Square House 10-12 Russell Square WC1B 5LF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BRITANNIC BUSINESS PARKS LIMITED | 10. Sept. 2002 | 10. Sept. 2002 |
| SOUTHTOUR LIMITED | 24. Jan. 2002 | 24. Jan. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Jan. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 23 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Mai 2012 | 18 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Elmsway (No1) Limited Hercules Business Park Lostock Lane Lostock Bolton BL6 4BR England am 02. Juni 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 5 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Canal Mill Botany Bay Villages Botany Brow Chorley Lancashire PR6 9AF am 22. Feb. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Jan. 2010 bis 30. Jan. 2010 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Knowles als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gerald Wood als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | LQ01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2009 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2008 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ELMSWAY (NO. 1) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARP, Claire Caroline | Sekretär | The Croft Blackburn Road, Higher Wheelton PR6 8HL Chorley Lancashire | British | 141979130001 | ||||||
| DIXON, William Ronald | Geschäftsführer | Cumberland Drive WA14 3QP Bowdon 27 Cheshire | England | British | 136501510001 | |||||
| HOPKINSON, Thomas Duncan | Geschäftsführer | Bank House Sawley Road Sawley BB7 4RS Clitheroe Lancashire | United Kingdom | British | 71862660002 | |||||
| SHARP, Claire Caroline | Geschäftsführer | The Croft Blackburn Road, Higher Wheelton PR6 8HL Chorley Lancashire | England | British | 141979130001 | |||||
| ALLEN, Rachel Mary | Sekretär | 1263 Burnley Road Loveclough BB4 8RG Rossendale Lancashire | British | 98369110001 | ||||||
| JENKINSON, Jayne Elizabeth | Sekretär | Inglemere Langley Lane, Goosnargh PR3 2JS Preston Lancashire | British | 85366800001 | ||||||
| SHARP, Claire Caroline | Sekretär | The Croft Blackburn Road, Higher Wheelton PR6 8HL Chorley Lancashire | British | 141979130001 | ||||||
| WESTHEAD, Paul | Sekretär | 11 Delph Way Whittle Le Woods PR6 7TG Chorley Lancashire | British | 72955010002 | ||||||
| BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | The Britannia Suite Lauren Court M33 2AF Wharf Road Sale Greater Manchester | 900018560001 | |||||||
| JENKINSON, Jayne Elizabeth | Geschäftsführer | Inglemere Langley Lane, Goosnargh PR3 2JS Preston Lancashire | England | British | 85366800001 | |||||
| KNOWLES, Timothy John Peter | Geschäftsführer | Clogh Willey Cottage Tosaby Road Stoney Mountain IM9 3AN St Marks Isle Of Man | Isle Of Man | British | 33274370003 | |||||
| WESTHEAD, Paul | Geschäftsführer | 11 Delph Way Whittle Le Woods PR6 7TG Chorley Lancashire | British | 72955010002 | ||||||
| WOOD, Gerald Jospeh | Geschäftsführer | 1 Stanley Road Farington PR25 4RH Leyland Lancashire | England | British | 110948700001 | |||||
| DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | The Britannia Suite Lauren Court M33 2AF Wharf Road Sale Greater Manchester | 900018550001 |
Hat ELMSWAY (NO. 1) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security deed | Erstellt am 12. Sept. 2006 Geliefert am 25. Sept. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each borrower to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Mai 2003 Geliefert am 17. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Brownlow business park tennyson street bolton. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Mai 2003 Geliefert am 17. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Florence business park whalley new road blackburn. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Mai 2003 Geliefert am 17. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Waverledge business park waverledge street great harwood blackburn. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Dez. 2002 Geliefert am 30. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second legal charge | Erstellt am 09. Juli 2002 Geliefert am 25. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The sum of £25,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Bronlow business park tennyson street bolton title number GM502273 waverledge mill waverledge street hyndburn title number LA36928 florence business park whaley new road blackburn title number LA386971 LA351831 LA351830 LA565627 LA374844 LA328794 together with all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery of the company from time to time thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Juli 2002 Geliefert am 25. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Bronlow business park tennyson street bolton title number GM502273 waverledge mill waverledge street hyndburn title number LA36928 florence business park whaley new road blackburn title numbers LA386971 LA351831 LA351830 LA565627 LA374844 LA328794 together with all buildings trade and other fixtures fixed plant fixed plant and machinery of the company from time to time thereon.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Juli 2002 Geliefert am 25. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Brownlow business park tennyson street bolton title number 502273, waverledge mill waverledge street hyndburn title number LA36928 florence business park whaley new road blackburn title numbers LA386971 LA351831 LA351830 LA565627 LA374844 LA328794. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 09. Juli 2002 Geliefert am 23. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/Hold property known as waterledge mill,great harwood,hyndburn,lancashire; la 36928;specific charge over all income and rights thereto and the proceeds of sale thereof,lease or other disposition and all deeds and documents thereto; all insurance and compensation monies; floating charge over all undertaking,property,assets and rights whatsoever; see form 395 for details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 08. Juli 2002 Geliefert am 23. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ELMSWAY (NO. 1) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Receiver/Manager bestellt |
| |||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0