MERCURY INNS GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMERCURY INNS GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04362325
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MERCURY INNS GROUP LIMITED?

    • (5211) /

    Wo befindet sich MERCURY INNS GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MERCURY INNS GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GW 154 LIMITED29. Jan. 200229. Jan. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MERCURY INNS GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis29. Feb. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für MERCURY INNS GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 14. Dez. 2010

    11 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Nov. 2010

    11 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Mai 2010

    12 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    3 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    65 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    5 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 111 Edmund Street Birmingham West Midlands B3 2HJ am 30. Nov. 2009

    1 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    5 SeitenMG01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 29. Feb. 2008

    29 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Sec 175 05/03/2009
    RES13

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    7 Seiten363a

    Beschlüsse

    Resolutions
    21 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Änderung der Aktienrechte oder der Bezeichnung

    RES12
    capital

    Beschluss zur Erhöhung des genehmigten Stammkapitals

    RES04
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    10 Seiten363s

    legacy

    3 Seiten395

    Konzernabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2007

    32 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten395

    legacy

    6 Seiten395

    legacy

    6 Seiten395

    legacy

    6 Seiten395

    legacy

    6 Seiten395

    legacy

    6 Seiten395

    legacy

    12 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von MERCURY INNS GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    THORNTON, Kevin
    10 Park View Road
    B74 4PP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Sekretär
    10 Park View Road
    B74 4PP Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishDirector44110490001
    HBJGW SECRETARIAL SUPPORT LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    93128710002
    BUTLER, Mark Leslie
    19 Boningale Way
    Dorridge
    B93 8SF Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    19 Boningale Way
    Dorridge
    B93 8SF Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishDirector53532870002
    CHAPMAN, Andrew Brian
    19 Aldershaws
    Shirley
    B90 1SQ Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    19 Aldershaws
    Shirley
    B90 1SQ Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishDirector70029870001
    THORNTON, Kevin
    10 Park View Road
    B74 4PP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    10 Park View Road
    B74 4PP Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishBritishDirector44110490001
    GW SECRETARIES LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    93128710001
    CAVE, Richard Michael
    The Acorns
    Main Street Illston On The Hill
    LE7 9EG Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    The Acorns
    Main Street Illston On The Hill
    LE7 9EG Leicester
    Leicestershire
    BritishCompany Director93362010001
    DICKSON, Peter Alan
    Pointer House Farm
    Langley Lane Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Pointer House Farm
    Langley Lane Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    BritishChartered Surveyor13332510001
    ISAACS, Paul
    136 Mill Lane
    B93 8NZ Bentley Heath
    West Midlands
    Geschäftsführer
    136 Mill Lane
    B93 8NZ Bentley Heath
    West Midlands
    BritishVenture Capitalist84187490001
    PERKINS, Colin Graham
    31 Copperkins Road
    WS12 5NW Hendesford
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    31 Copperkins Road
    WS12 5NW Hendesford
    Staffordshire
    BritishOperations Director80732380001
    GW INCORPORATIONS LIMITED
    Windsor House
    3 Temple Row
    B2 5JR Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Windsor House
    3 Temple Row
    B2 5JR Birmingham
    West Midlands
    68279000001

    Hat MERCURY INNS GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 11. Nov. 2009
    Geliefert am 26. Nov. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or mercury inns to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a park inn 98 kim bolton road bedford t/no BD253825.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Mai 2008
    Geliefert am 17. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H the olde coach house ashby st ledgers daventry northamptonshire. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    A second ranking legal charge
    Erstellt am 06. Nov. 2007
    Geliefert am 21. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or titleholder to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/Hold property premises and buildings known as meynell ingram arms,hoar cross,staffs; t/no SF345688; all fixtures and fittings thereon and goodwill of business; the benefit of licences; fixed charge over all insurance proceeds in respect of undertaking,property and assets; floating charge over all undertaking property and assets whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcastle UK Limited
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 06. Nov. 2007
    Geliefert am 12. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the trading companies on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All proceeds due to the company of insurance maintained in respect of the undertaking property and assets; all goods and movable fittings which do not form part of the company's stock in trade; floating charge over the whole of the company's undertaking.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcastle UK Limited
    Transaktionen
    • 12. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Nov. 2007
    Geliefert am 12. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or the titleholder to the chargee and/or the trading companies on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H the walton arms burnley road altham nr accrington t/no LA730290 together with all additions to the said property premises and buildings and all fixutures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcaslte UK Limited
    Transaktionen
    • 12. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Nov. 2007
    Geliefert am 12. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or the titleholder to the chargee and/or the trading companies on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H villa (the) moss side lane wrea green preston t/nos LA730321 LA839706 together with all additions to the said property premises and buildings and all fixutures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcaslte UK Limited
    Transaktionen
    • 12. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Nov. 2007
    Geliefert am 12. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or the titleholder to the chargee and/or the trading companies on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H the red lion ramsbottom hawkshaw bury t/no LA622113 LA441427 LA619555 and LA394825 together with all additions to the said property premises and buildings and all fixutures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcaslte UK Limited
    Transaktionen
    • 12. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Nov. 2007
    Geliefert am 12. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the trading companies on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The samuel pepys 31 slipton lane sliton near kettering northamptonshire t/no NN111253 together with all additions to the said property premises and buildings and all fixutures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcaslte UK Limited
    Transaktionen
    • 12. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Apr. 2006
    Geliefert am 18. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H the samuel pepys slipton lane near kettering northamptonshire t/no nn 111253.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Apr. 2006
    Geliefert am 18. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H the old green man public house watling street little brickhill milton keynes buckinghamshire t/no bm 301585.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 07. Apr. 2006
    Geliefert am 19. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Juni 2005
    Geliefert am 21. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a the old green man, watling street, little brickhill, milton keynes, buckinghamshire. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 21. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Aug. 2003
    Geliefert am 08. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The samuel pepys, slipton, east northamptonshire t/n NN111253. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 04. März 2002
    Geliefert am 21. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Afm Nominees Limited a/C Adc,Murray VCT3 PLC,Murray VCT4 PLC,Venture Nominees West Tamesidemetropolitan Borough Council,West Yorkshire Pension Fund Yorkshire Investors and Aberdeen Growth VCT1 PLC
    Transaktionen
    • 21. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 04. März 2002
    Geliefert am 15. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 15. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 04. März 2002
    Geliefert am 15. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The full benefit of life policy number 6004180 in respect of kevin thornton and entered into between the company and canada life limited.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 15. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 04. März 2002
    Geliefert am 15. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The full benefit of the life policy number 6004179 in respect of mark butler and entered into between the company and canada life limited.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 15. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. März 2002
    Geliefert am 08. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of assignment all its rights and title (if any) in respect of the goodwill of the business by way of assignment all justices licences and any public entertainment licences by way of fixed charge all proceeds due to the company by way of fixed charge all goods and movable fittings by way of floating charge the whole of the company's undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Scottish Courage Limited
    Transaktionen
    • 08. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MERCURY INNS GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    14. Dez. 2010Ende der Verwaltung
    23. Nov. 2009Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Antony David Nygate
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Tracey Lee Pye
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0