SHIPS ONE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSHIPS ONE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04364472
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SHIPS ONE LIMITED?

    • (7487) /

    Wo befindet sich SHIPS ONE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Fletcher King
    61 Conduit Street
    W1S 2GB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SHIPS ONE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CULOTTE LIMITED31. Jan. 200231. Jan. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SHIPS ONE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für SHIPS ONE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Umregistrierung

    RES02

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92
    RWVZGE4F

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    legacy

    1 Seiten652a
    AV54FYZQ

    legacy

    3 Seiten363a
    XKWVLXPF

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    8 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006

    9 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2005

    9 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    11 Seiten395

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2004

    9 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten395

    legacy

    11 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von SHIPS ONE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROBERTSON, James Andrew Stuart
    9 Hurlingham Court Mansions
    SW6 3RE London
    Sekretär
    9 Hurlingham Court Mansions
    SW6 3RE London
    BritishChartered Secretary1946690001
    FLETCHER, David Jonathan Richard
    39 Gilston Road
    SW10 9SJ London
    Geschäftsführer
    39 Gilston Road
    SW10 9SJ London
    United KingdomBritishChartered Surveyor10597290003
    GOODE, Richard Eric Greenway
    5 The Mount
    KT10 8LQ Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    5 The Mount
    KT10 8LQ Esher
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor30515220003
    CROWCROFT, Christopher Rhodes
    12 The Drove
    Horton Heath
    SO50 7NW Eastleigh
    Hampshire
    Sekretär
    12 The Drove
    Horton Heath
    SO50 7NW Eastleigh
    Hampshire
    BritishAccountant45695620001
    EVANS, David Malcolm
    Stratton House
    Stratton Street
    W1J 8LA London
    Sekretär
    Stratton House
    Stratton Street
    W1J 8LA London
    British10265160001
    GOODE, Richard Eric Greenway
    5 The Mount
    KT10 8LQ Esher
    Surrey
    Sekretär
    5 The Mount
    KT10 8LQ Esher
    Surrey
    British30515220003
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Hat SHIPS ONE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 22. Dez. 2004
    Geliefert am 23. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. Juli 2004
    Geliefert am 04. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a block 5 blackbrook valley, peartree lane, netherton, dudley, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 29 july 2004 and
    Erstellt am 16. Juli 2004
    Geliefert am 07. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Block 6 cartside avenue inchinnan business park renfrew t/no ren 102260.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 09. Juli 2004
    Geliefert am 14. Juli 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by each borrower to the lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 14. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 9 july 2004 and
    Erstellt am 06. Juli 2004
    Geliefert am 17. Juli 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and ships two limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The subjects known as and forming 4, 8 and 12 minerva way, finnieston, glasgow t/n GLA43100.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 17. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 03. Feb. 2004
    Geliefert am 12. Feb. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the mortgaged property and the shares, the properties being office village phase one, cardiff gate business park cardiff and europe trading estate stoneclough road in each case as more particularly defined in the debenture rental income licences in relation to the real property goodwill book and other debts investments and assets by way of first floating charge all present and future assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 29. Sept. 2003
    Geliefert am 07. Okt. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by the company and ships two limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a beaufort office park, almondsbury, bristol, t/n AV178232,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0