ASPECT PROPERTY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameASPECT PROPERTY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04366485
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ASPECT PROPERTY LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich ASPECT PROPERTY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Haslers
    Old Station Road
    IG10 4PL Loughton
    Essex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASPECT PROPERTY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Feb. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ASPECT PROPERTY LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für ASPECT PROPERTY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. März 2014

    Kapitalaufstellung am 20. März 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01
    X340ZJXK

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 28. Feb. 2013

    6 SeitenAA
    L2M5WR8R

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    X242NW83

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 29. Feb. 2012

    6 SeitenAA
    A1A0HRY8

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Aug. 2011 bis 29. Feb. 2012

    1 SeitenAA01
    X18NWSDM

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    X170IACX

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2010

    6 SeitenAA
    L6J27ULY

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    XI6KSTUK

    legacy

    3 SeitenMG02
    A8O73NHK

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2009

    7 SeitenAA
    LNAMDKDE

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    XA04RIQA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2008

    6 SeitenAA
    AJ7EJ85A

    legacy

    4 Seiten363a
    XXCRN82U

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2007

    5 SeitenAA
    AKOBP0WE

    legacy

    4 Seiten363a
    XTUGFYV8

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2006

    6 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2005

    5 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2004

    7 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2003

    7 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von ASPECT PROPERTY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FLYS, Dawn
    13 First Avenue
    HP7 9BJ Amersham
    Buckinghamshire
    Sekretär
    13 First Avenue
    HP7 9BJ Amersham
    Buckinghamshire
    BritishPersonal Assistant39986470002
    FLYS, Dawn
    13 First Avenue
    HP7 9BJ Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    13 First Avenue
    HP7 9BJ Amersham
    Buckinghamshire
    BritishPersonal Assistant39986470002
    FLYS, Marko
    13 First Avenue
    HP7 9BJ Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    13 First Avenue
    HP7 9BJ Amersham
    Buckinghamshire
    BritishMedia Buyer39986480002
    SDG SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900023580001
    SDG REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900023570001

    Hat ASPECT PROPERTY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 08. Mai 2003
    Geliefert am 09. Mai 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold property known as 6 europa house,marsham way,gerrards cross,buckinghamshire SL9 8BQ; t/no BM62249. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Security over a deposit account
    Erstellt am 12. Dez. 2002
    Geliefert am 20. Dez. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right, title and interest in the monies held in an account.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Sept. 2002
    Geliefert am 28. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 11 kings lock apsley hertfordshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Aug. 2002
    Geliefert am 28. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that freehold property known as 12 russell court chesham buckinghamshire HP5 3JJ t/n BM220826. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Aug. 2002
    Geliefert am 16. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that leasehold property known as 4 masons court berkhampstead road chesham. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 13. Aug. 2002
    Geliefert am 16. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0