365 IT SUBCO NO.1 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04366702 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED?
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Napoleon House Riseley Business Park, Basingstoke Road Riseley RG7 1NW Reading England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| 5I LIMITED | 05. Feb. 2002 | 05. Feb. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 15 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 4 Cartel Business Centre Stroudley Road Basingstoke Hampshire RG24 8FW am 10. Apr. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Maclean als Geschäftsführer am 22. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed 5I LIMITED\certificate issued on 01/12/11 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2010 bis 30. Juni 2011 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Ernennung von Mb Secretaries Limited als Sekretär | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alastair Ferguson als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alastair Ferguson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Alastair William Ferguson als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Hearn als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Hearn als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Alastair William Ferguson als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 12 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für David Gareth Hearn am 05. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB SECRETARIES LIMITED | Sekretär | The Avenue SO17 1XF Southampton 11 Hampshire United Kingdom |
| 124285230001 | ||||||||||
| ALLAN, Keith Andrew | Geschäftsführer | 16 Sovereign Close CV8 1SQ Kenilworth Warwickshire | United Kingdom | British | 100161360001 | |||||||||
| BROWN, Richard William | Geschäftsführer | 24a Alma Road SL4 3HL Windsor Berkshire | England | British | 100161150001 | |||||||||
| HOWELLS, Peter Hugh | Geschäftsführer | Centurion House 11 Romans Field, RG7 2QH Silchester Berkshire | England | British | 163030330001 | |||||||||
| FERGUSON, Alastair William | Sekretär | Stroudley Road RG24 8FW Basingstoke 4 Cartel Business Centre Hampshire | 154526830001 | |||||||||||
| HEARN, David Gareth | Sekretär | Middle Prospect New Road OX18 2LF Bampton Oxfordshire | British | 59462210001 | ||||||||||
| ORCHARD, Clive | Sekretär | Birchtree Cottages Kings Road Silchester RG7 2NT Reading 2 Berkshire United Kingdom | British | 81052720003 | ||||||||||
| BOYES TURNER SECRETARIES LIMITED | Sekretär | First Floor Abbots House Abbey Street RG1 3BD Reading Berkshire | 74407280002 | |||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| FERGUSON, Alastair William | Geschäftsführer | Stroudley Road RG24 8FW Basingstoke 4 Cartel Business Centre Hampshire | England | British | 125179970001 | |||||||||
| HEARN, David Gareth | Geschäftsführer | Stroudley Road RG24 8FW Basingstoke 4 Cartel Business Centre Hampshire | United Kingdom | British | 59462210001 | |||||||||
| MACLEAN, Peter | Geschäftsführer | Steventon Manor RG25 3BE Steventon Hampshire | United Kingdom | British | 157773140001 | |||||||||
| ORCHARD, Clive | Geschäftsführer | 47 Jubilee Close Pamber Heath RG26 3HP Tadley Hampshire | British | 81052720002 | ||||||||||
| RANSOM, Graham Richard | Geschäftsführer | 8 Fairacre Woolton Hill RG20 9UF Newbury Berkshire | Uk | British | 34690210001 | |||||||||
| STEVENS, Terrence | Geschäftsführer | 17 Elliott Rise SL5 8NN North Ascot Berkshire | British | 81052700001 | ||||||||||
| BOYES TURNER DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | First Floor Abbots House Abbey Street RG1 3BD Reading Berkshire | 101374610001 | |||||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat 365 IT SUBCO NO.1 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Erstellt am 28. Apr. 2010 Geliefert am 29. Apr. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All monies from time to time standing to the credit of the interest bearing deposit account operated by field seymour parks as solicitors for the landlord under the lease pursuant to the terms of the said rent deposit deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 30. Nov. 2007 Geliefert am 08. Dez. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Sept. 2006 Geliefert am 19. Sept. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 08. Mai 2006 Geliefert am 09. Mai 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All monies from time to time standing to the credit of the interest-bearing deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Feb. 2005 Geliefert am 22. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rental deposit deed | Erstellt am 08. Apr. 2004 Geliefert am 23. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All monies from time to time standing to the credit of the interest bearing deposit account pursuant to the terms of the rental deposit deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 17. Juli 2002 Geliefert am 23. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £6,750.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The sum of £6,750.00. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0