OBJECTIVE KEYSTONE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | OBJECTIVE KEYSTONE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04372883 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OBJECTIVE KEYSTONE LIMITED?
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich OBJECTIVE KEYSTONE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Level 10 Thames Tower Station Road RG1 1LX Reading Berkshire England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von OBJECTIVE KEYSTONE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LIMEHOUSE SOFTWARE LIMITED | 14. Dez. 2004 | 14. Dez. 2004 |
| LIMEHOUSE INTERACTIVE LIMITED | 13. März 2002 | 13. März 2002 |
| ERCILLA LIMITED | 13. Feb. 2002 | 13. Feb. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OBJECTIVE KEYSTONE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2023 |
Welche sind die letzten Einreichungen für OBJECTIVE KEYSTONE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2023 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 26. Juni 2023
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2022 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2021 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2020 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom St Cloud Gate St Cloud Way Cookham Road Maidenhead Berkshire SL6 8XD zum Level 10 Thames Tower Station Road Reading Berkshire RG1 1LX am 13. März 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Tony Brian Walls am 19. Dez. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Ben Tregoning als Sekretär am 02. Sept. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von OBJECTIVE KEYSTONE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREGONING, Ben | Sekretär | Thames Tower Station Road RG1 1LX Reading Level 10 Berkshire England | 224866870001 | |||||||
| KINGSBURY, Nicholas John | Geschäftsführer | 8 Parkland Drive AL3 4AH St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 107481320001 | |||||
| WALLS, Tony Brian | Geschäftsführer | Level 30 Pacific Highway North Sydney Objective Corporation Ltd Nsw 2060 Australia | Australia | Australian | 137482190002 | |||||
| CASEY, Helen | Sekretär | St Cloud Way Cookham Road SL6 8XD Maidenhead St Cloud Gate Berkshire | 170467850001 | |||||||
| KATZ, Mark | Sekretär | Level 37, 100 Miller Street, North Sydney Sydney Objective Corporation New South Wales 2060 Australia | 205963850001 | |||||||
| KINGSBURY, Nicholas John | Sekretär | 8 Parkland Drive AL3 4AH St Albans Hertfordshire | British | 107481320001 | ||||||
| PATERSON, Robert | Sekretär | St Cloud Way Cookham Road SL6 8XD Maidenhead St Cloud Gate Berkshire | 199824820001 | |||||||
| BMAS LIMITED | Sekretär | Old Garden House The Lanterns SW11 3AD London 3 | 129382530001 | |||||||
| MCLAREN COSEC LIMITED | Sekretär | 3 Old Garden House The Lanterns Bridge Lane SW11 3AD London | 78306640001 | |||||||
| COPLAND, Christopher Ainslie | Geschäftsführer | 37 Cathles Road Balham SW12 9LE London | British | 82417410001 | ||||||
| HOPPER, Edward Piers | Geschäftsführer | Ormeley Road SW12 9QG London 54 United Kingdom | United Kingdom | British | 132593440001 | |||||
| MACKENZIE, Colin | Geschäftsführer | High Street Cricklade SN6 6DF Swindon 23 United Kingdom | United Kingdom | British | 132597020001 | |||||
| SMITH, Martin Brian | Geschäftsführer | 8 Backwoods Lane Lindfield RH16 2ED Haywards Heath West Sussex | England | British | 110165990001 | |||||
| WELCH, Giles Michael John | Geschäftsführer | Hardings Green Cookham SL6 9NX Maidenhead Merlins Berkshire United Kingdom | England | English | 109909750002 | |||||
| THE DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Oceanic Suite, Docklands Innovation Park, 128-130 East Wall Road, IRISH Dublin 3 Ireland | 77210180003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei OBJECTIVE KEYSTONE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objective Corporation Ltd | 06. Apr. 2016 | 177 Pacific Highway North Sydney Level 30 Nsw 2060 Australia | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat OBJECTIVE KEYSTONE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Erstellt am 11. Juli 2008 Geliefert am 12. Juli 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben £58,750.00. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Erstellt am 12. Juni 2008 Geliefert am 19. Juni 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Company: the standard life assurance company, policy number: x 73628330, date: 28/11/2002, sum: £750000, life assured: mr giles welch together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture containing fixed and floating charges | Erstellt am 08. Mai 2008 Geliefert am 10. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 20. März 2007 Geliefert am 29. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The rent deposit monies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Nov. 2004 Geliefert am 09. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0